Buscador CIF Logo

Actos BORME Cronodis Logistica Integral Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cronodis Logistica Integral Sociedad Limitada

Actos BORME Cronodis Logistica Integral Sociedad Limitada - B19236728

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Guadalajara para Cronodis Logistica Integral Sociedad Limitada con CIF B19236728

馃敊 Perfil de Cronodis Logistica Integral Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Guadalajara

Actos BORME de Cronodis Logistica Integral Sociedad Limitada

24 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO;JESUS LOPEZ DIAZ;BRAVO SILVA MARTA. Datosregistrales. T 625 , F 225, S 8, H GU 5807, I/A 30 (10.03.23).

13 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: ERNESTO SANTOS MARTIN. Datos registrales. T 625 , F 225, S 8, H GU 5807, I/A 29 (24.02.23).

02 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: JESUS LOPEZ DIAZ;BRAVO SILVA MARTA;LIDIA PASAMAR LORENZO;LUIS ORTEGO MAGANO.Datos registrales. T 625 , F 223, S 8, H GU 5807, I/A 28 (22.02.23).

02 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA VALENCIA BELEN. Apo.Man.Soli: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO. Datos registrales. T 625 ,F 223, S 8, H GU 5807, I/A 27 (19.12.22).

25 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SERRANO BUSTAMANTE JORGE;CABALLERO JULIA FERNANDO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: BRAVO SILVA MARTA. Datos registrales. T 625 , F 222, S 8, H GU 5807, I/A 26 (13.11.20).

29 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GRUPO CRONOS DISTRIBUCION INTEGRAL S.L. Nombramientos. Adm. Unico:DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA S.L. Datos registrales. T 594 , F 176, S 8, H GU 5807, I/A 23 (11.04.19).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA S.L. Datos registrales. T 594 , F 177, S8, H GU 5807, I/A 24 (11.04.19).

Revocaciones. Apoderado: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;BERTOLOOTERO JOSE ROBERTO;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL;LOPEZ DIAZ JESUS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRANO BUSTAMANTE JORGE;LOPEZ DIAZ JESUS;VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO;CABALLERO JULIA FERNANDO. Datos registrales. T 594 , F 177, S 8, H GU 5807, I/A 25(11.04.19).

25 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA VALENCIA BELEN;ORTEGA MARTINEZ ANDRES;MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER.Nombramientos. Apo.Sol.: BRAVO SILVA MARTA;GARCIA VALENCIA BELEN;REINA VALENCIA ROBERTO. Datos registrales. T594 , F 175, S 8, H GU 5807, I/A 22 (15.01.19).

26 de Enero de 2018
Nombramientos. Apoderado: BOYACA SERVICIOS CORPORATIVOS SL. Datos registrales. T 594 , F 173, S 8, H GU 5807, I/A 20(18.01.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASTILLA PEINADO PEDRO;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;CA脩ADAS AROCENA MERCEDES.Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;BERTOLO OTERO JOSE ROBERTO;SERRANO GONZALEZCASTO-MANUEL;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL;LOPEZ DIAZ JESUS. Datos registrales. T 594 , F 174, S 8, H GU 5807, I/A 21(18.01.18).

01 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. AVDA LA BALLESTERA 4 - POLIGONO SECTOR I-3, PARCEL (ALOVERA). Datos registrales. T 594, F 173, S 8, H GU 5807, I/A 19 (22.11.17).

09 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: GODOY MEDINA MARIA DEL MAR;ORTEGA MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 579 , F 51, S 8,H GU 5807, I/A 17 ( 2.10.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MARTINEZ ANDRES;GARCIA VALENCIA BELEN;MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER. Datosregistrales. T 579 , F 51, S 8, H GU 5807, I/A 18 ( 2.10.15).

06 de Febrero de 2015
Nombramientos. Auditor: DELOITTE S.L. Aud.C.Con.: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 579 , F 51, S 8, H GU 5807, I/A 16(28.01.15).

29 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 579 , F 49, S 8, H GU 5807, I/A 13(17.12.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTILLA PEINADO PEDRO;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;CA脩ADAS AROCENA MERCEDES.Datos registrales. T 579 , F 49, S 8, H GU 5807, I/A 14 (17.12.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: GODOY MEDINA MARIA DEL MAR;ORTEGA MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 579 , F 50, S8, H GU 5807, I/A 15 (17.12.14).

06 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RUIZ ESTEBAN ALFONSO;REDPRENSA S.L. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO CRONOSDISTRIBUCION INTEGRAL S.L. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 579 , F 48, S 8, H GU 5807, I/A 12 (16.04.14).

27 de Septiembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOINAZ JAIME JOSE-MARIA. Nombramientos. Adm. Solid.: RUIZ ESTEBAN ALFONSO.Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 456 , F 201, S 8, H GU 5807, I/A 10 (18.09.13).

20 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 456 , F 200, S 8, H GU 5807, I/A 9 (8.08.13).

30 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 456 , F 200, S 8, H GU 5807, I/A 8 ( 9.10.12).

14 de Febrero de 2012
Otros conceptos: Sustituci贸n de don Ovidio Ram贸n Cecos por don Juan Manuel Albelda Mart铆n como representante persona f铆sicade la mercantil REDPRENSA, S.L., en su cargo de Administradora Solidariade CRONODIS LOGISTICA INTEGRAL, S.L. Datosregistrales. T 456 , F 200, S 8, H GU 5807, I/A 7 (10.01.12).

25 de Octubre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 456 , F 199, S 8, H GU 5807, I/A 6 (24.09.11).

30 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 456 , F 199, S 8, H GU 5807, I/A 5 (10.11.10).

29 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 456 , F 199, S 8, H GU 5807, I/A 4 (15.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n