Actos BORME de Ctl Spain Sl
21 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: LEDO ARIAS MARUXA. Datos registrales. T 4069, L 4069, F 218, S 8, H PO 59071, I/A 10 (13.02.23).
20 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAMALLO GARCIA HUGO ENRIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: STROMQUIST ERIK. Datosregistrales. T 4069, L 4069, F 218, S 8, H PO 59071, I/A 9 ( 8.02.23).
10 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: ABUIN FERNANDEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4069, L 4069, F 218, S 8, H PO 59071,I/A 8 ( 1.02.23).
09 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: PORRAS PEDRAZA JUAN;LIÑAN BERNARDO JULIA. Datos registrales. T 4069, L 4069, F 217, S 8, HPO 59071, I/A 7 ( 1.02.23).
11 de Marzo de 2022Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 4069, L 4069, F 217, S 8, H PO 59071, I/A 6 (3.03.22).
11 de Noviembre de 2020Cambio de domicilio social. CTRA DE MADRID Km 152 1ª (VIGO). Datos registrales. T 4069, L 4069, F 217, S 8, H PO 59071, I/A5 (30.10.20).
28 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. C/ PONTEVEDRA 8 1ª - OFICINA 6 (VIGO). Datos registrales. T 4069, L 4069, F 216, S 8, H PO59071, I/A 4 (20.02.19).
06 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: ABUIN FERNANDEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4069, L 4069, F 216, S 8, H PO 59071,I/A 3 (29.05.18).
16 de Abril de 2018Cambio de domicilio social. C/ DOCTOR CADAVAL 21 2º - OFICINA 10 (VIGO). Datos registrales. T 4069, L 4069, F 215, S 8, HPO 59071, I/A 2 ( 5.04.18).
08 de Octubre de 2015Constitución. Comienzo de operaciones: 25.09.15. Objeto social: El comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos yprogramas informáticos (CNAE 4651). Domicilio: LUGAR LARACHE 113 (VILABOA). Capital: 14.731,00 Euros. Declaración deunipersonalidad. Socio único: COMPUTER TECHNOLOGY LINK CORP. Nombramientos. Adm. Unico: RAMALLO GARCIAHUGO ENRIQUE. Datos registrales. T 4069, L 4069, F 215, S 8, H PO 59071, I/A 1 (30.09.15).