Actos BORME de Cualicontrol Aci Sa
20 de Noviembre de 2023Cambio de domicilio social. C/ HAYA 7 A 2陋 (MADRID). Datos registrales. T 35681 , F 37, S 8, H M 79650, I/A 100 (13.11.23).
13 de Noviembre de 2023Otros conceptos: Se subsana la inscripci贸n 98陋 en el sentido de hacer constar que se public贸 como unos de los apoderados a DonManuel Antonio Faus Mart铆nez cuando en realidad es Don Manuel Antonio Mart铆nez Faus. Datos registrales. T 35681 , F 37, S 8, HM 79650, I/A 99 ( 3.11.23).
07 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FAUS MARTINEZ MANUEL ANTONIO;BRINES BENLLIURE RICARDO. Datos registrales. T 35681 , F36, S 8, H M 79650, I/A 98 (31.05.23).
01 de Junio de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BRA脩UELAS QUIROGA JAIME. Ceses/Dimisiones. Consejero:WIEGELMANN VOLKER;SENDKER ANATOL. Presidente: SENDKER ANATOL. Consejero: BRUHN JORN. VsecrNoConsj: MCGAULEY NICOLAS CRISTOBAL TORIBIO. SecreNoConsj: KIRCHHEIM PHILIPP HERRMANN WERNER. Nombramientos. Adm.Unico: BRA脩UELAS QUIROGA JAIME. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 35681 , F 36, S 8, H M 79650, I/A 96 (25.05.23).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PGASUS WORLDWIDE INVESTMENTS SL. Datos registrales. T35681 , F 36, S 8, H M 79650, I/A 97 (25.05.23).
22 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ MIRANDA ALEJANDRO. Datos registrales. T 35681 , F 35, S 8, H M 79650, I/A 95 (15.12.22).
12 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: BRINES BENLLIURE RICARDO;BRINES BENLLIURE RICARDO. Otros conceptos: Modificado elpoder conferido a Don David Paz Castro en virtud de escritura otorgada el 7 de julio de 2022 ante el notario de Barcelona Don EduardoBautista Bl谩zquez con el n煤mero de protocolo 1892, que caus贸 la inscripci贸n 92陋. Se rectifica el primer apellido del apoderado DonRicardo Brinez Benlliuro, ya que el correcto es "Brines". Datos registrales. T 35681 , F 35, S 8, H M 79650, I/A 94 ( 1.12.22).
29 de Julio de 2022Nombramientos. Apoderado: PAZ CASTRO DAVID;PAZ CASTRO DAVID;BRINEZ BENLLIURE RICARDO;BRINEZ BENLLIURERICARDO. Datos registrales. T 35681 , F 33, S 8, H M 79650, I/A 92 (21.07.22).
Reelecciones. Consejero: BRUHN JORN. Datos registrales. T 35681 , F 35, S 8, H M 79650, I/A 93 (21.07.22).
03 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35681 , F 32, S 8, H M 79650, I/A 91 (25.04.22).
27 de Septiembre de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP. Representan: ABEGGGEORG CHRISTIAN. VsecrNoConsj: MARES SALVADOR RAMON. Nombramientos. SecreNoConsj: KIRCHHEIM PHILIPPHERRMANN WERNER. VsecrNoConsj: MC GAULEY NICOLAS CRISTOBAL TORIBIO. Datos registrales. T 35681 , F 32, S 8, H M79650, I/A 90 (20.09.21).
16 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35681 , F 32, S 8, H M 79650, I/A 89 ( 9.09.21).
05 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PETERSEN ASTRID. Presidente: PETERSEN ASTRID. Nombramientos. Consejero: SENDKERANATOL. Presidente: SENDKER ANATOL. Reelecciones. Consejero: WIEGELMANN VOLKER. Cambio de domicilio social. C/CALERUEGA 102-104 - 2陋 PLANTA DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 35681 , F 31, S 8, H M 79650, I/A 88 (27.04.21).
29 de Agosto de 2019Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35681 , F 31, S 8, H M 79650, I/A 87 (22.08.19).
07 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: THEIKE ULF PETER. Presidente: THEIKE ULF PETER. Nombramientos. Consejero: PETERSENASTRID. Presidente: PETERSEN ASTRID. Datos registrales. T 35681 , F 31, S 8, H M 79650, I/A 86 (31.07.19).
06 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTIN JOSE MANUEL. Nombramientos. Representan: ABEGG GEORG CHRISTIAN.VsecrNoConsj: MARES SALVADOR RAMON. Reelecciones. SecreNoConsj: RODL & PARTNER ABOGADOS Y ASESORESTRIBUTARIOS SLP. Datos registrales. T 35681 , F 30, S 8, H M 79650, I/A 84 (30.01.19).
Cambio de objeto social. Intermediaci贸n en servicios t茅cnicos de ingenier铆a; - Ensayos y an谩lisis t茅cnicos; - Investigaci贸n ydesarrollo; - Certificaci贸n de sistemas y personas; - Formaci贸n T茅cnica. Datos registrales. T 35681 , F 30, S 8, H M 79650, I/A 85(30.01.19).
05 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35681 , F 29, S 8, H M 79650, I/A 83 (26.10.18).
08 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHOEN YVES JEAN-GUSTAVE. Presidente: SCHOEN YVES JEAN-GUSTAVE. Nombramientos.Consejero: THEIKE ULF PETER. Presidente: THEIKE ULF PETER. Datos registrales. T 35681 , F 29, S 8, H M 79650, I/A 82 (1.02.18).
04 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35681 , F 29, S 8, H M 79650, I/A 81 (26.09.17).
07 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LOS SANTOS YEBENES ELISA;GARCIA MARTIN JOSE MANUEL. Apo.Manc.: MARTINEZCACERES JOSE RAMON;ROMEU CRESPO JORDI. Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARTIN JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 35681 , F 29, S 8, H M 79650, I/A 80 (30.08.17).
05 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: JUNG RALF GUNTER. Nombramientos. Consejero: BRUHN JORN. Datos registrales. T 35681 , F26, S 8, H M 79650, I/A 78 (28.08.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ MIRANDA ALEJANDRO. Datos registrales. T 35681 , F 26, S 8, H M 79650, I/A 79 (28.08.17).
04 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apoderado: SANTOS MAZA MARI SOL;SANTOS MAZA MATILDE;INDUS GMBH;EUMANN KLAUE DORIT;LAGOCOLLAZO EUSTAQUIO OLEGARIO;HERNANDO MACHIN BALTASAR. Apo.Man.Soli: DE LOS SANTOS YEBENES ELISA. Datosregistrales. T 35681 , F 26, S 8, H M 79650, I/A 77 (25.08.17).
10 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35681 , F 26, S 8, H M 79650, I/A 76 ( 1.03.17).
17 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: NOGUEIRA DE MELLO SERGIO;NOGUEIRA DE MELLO SERGIO;MARTINEZ DOPICOFRANCISCO;DE LOS SANTOS YEBENES ELISA. Apo.Manc.: MARTINEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER;DE LOS SANTOSYEBENES ELISA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LOS SANTOS YEBENES ELISA;GARCIA MARTIN JOSE MANUEL.Apo.Manc.: MARTINEZ CACERES JOSE RAMON;ROMEU CRESPO JORDI. Datos registrales. T 25055 , F 223, S 8, H M 79650, I/A75 ( 6.05.16).
22 de Diciembre de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: TUV NORD INTERNATIONAL GMBH&CO.KG. Ceses/Dimisiones.Representan: MARTINEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER. Consejero: TUV NORD IBERIA SL. Con.Delegado: TUV NORD IBERIA SL.Consejero: HIMMELSBACH JURGEN MICHAEL. Nombramientos. Consejero: WIEGELMANN VOLKER. Datos registrales. T25055 , F 223, S 8, H M 79650, I/A 74 (15.12.15).
09 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 25055 , F 222, S 8, H M 79650, I/A 73 (30.09.15).
22 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: STENKAMP DIRK;BECKER STEFAN DETLEF. Presidente: STENKAMP DIRK. Nombramientos.Consejero: SCHOEN YVES JEAN-GUSTAVE. Presidente: SCHOEN YVES JEAN-GUSTAVE. Datos registrales. T 25055 , F 222, S8, H M 79650, I/A 72 (13.05.14).
24 de Abril de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER;DE LOS SANTOS YEBENES ELISA. Datos registrales. T25055 , F 222, S 8, H M 79650, I/A 71 (14.04.14).
15 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TUV NORD IBERIA SL. Representan: MARTINEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Representan: MARTINEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER. Consejero: STENKAMP DIRK;BECKER STEFANDETLEF;HIMMELSBACH JURGEN MICHAEL;JUNG RALF GUNTER;TUV NORD IBERIA SL. Presidente: STENKAMP DIRK.Con.Delegado: TUV NORD IBERIA SL. Representan: ABEGG GEORG-CHRISTIAN. SecreNoConsj: RODL & PARTNER ABOGADOSY ASESORES TRIBUTARIOS SLP. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n.- Modificaci贸n parcial de Estatutos, nueva redacci贸n del articulo 18, art铆culo 19 y creaci贸n deun art铆culonuevo el 19bis. Datos registrales. T 25055 , F 158, S 8, H M 79650, I/A 70 ( 7.11.13).
23 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 25055 , F 158, S 8, H M 79650, I/A 69 (10.10.12).
22 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: DAZA SAUCEDO JOSE;DAZA SAUCEDO JOSE;RAUH IVO;DAZA SAUCEDO JOSE;RAUH IVO;DAZASAUCEDO JOSE;DAZA SAUCEDO JOSE. Datos registrales. T 25055 , F 158, S 8, H M 79650, I/A 68 (13.06.12).
03 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RAUH IVO WOLFRAM. Nombramientos. Adm. Unico: TUV NORD IBERIA SL. Representan:MARTINEZ DOPICO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 25055 , F 157, S 8, H M 79650, I/A 67 (22.03.12).
07 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DOPICO FRANCISCO;RAUH IVO WOLFRAM;DE LOS SANTOS YEBENES ELISA;DAZASAUCEDO JOSE. Datos registrales. T 25055 , F 154, S 8, H M 79650, I/A 66 (27.01.12).
20 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LOS SANTOS YEBENES ELISA. Apo.Manc.: DAZA SAUCEDO JOSE. Datos registrales. T25055 , F 154, S 8, H M 79650, I/A 65 ( 7.12.11).
07 de Diciembre de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: TUV NORD IBERIA SL. Ceses/Dimisiones. Consejero:KLOSOWSKI VOLKER. Presidente: KLOSOWSKI VOLKER. Consejero: BECKER STEFAN;HIMMELSBACH JURGEN;RAUH IVO.Secretario: RAUH IVO. Nombramientos. Adm. Unico: RAUH IVO WOLFRAM. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.- Modificaci贸n parcial de Estatutos e introducci贸n de un nuevo textode los mismos . Datos registrales. T 25055 , F 150, S 8, H M 79650, I/A 64 (24.11.11).
16 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RAUH IVO. Reelecciones. Consejero: RAUH IVO. Secretario: RAUH IVO. Datos registrales. T25055 , F 150, S 8, H M 79650, I/A 63 ( 3.08.11).
19 de Octubre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 702.000,00 Euros. Desembolsado: 702.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.505.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.505.000,00 Euros. Datos registrales. T 25055 , F 149, S 8, H M 79650, I/A 62 ( 6.10.10).
18 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHMITZ ANDREAS. Nombramientos. Consejero: HIMMELSBACH JURGEN. Datos registrales.T 25055 , F 148, S 8, H M 79650, I/A 61 ( 5.10.10).
09 de Febrero de 2010Ampliacion del objeto social. IMPARTICION DE CURSOS EN SENTIDO AMPLIO DE FORMACION NO REGLADA Y FORMACIONPARA LA OBTENCION DE CARNETS PROFESIONALES ORIENTADA A PERSONAS O EMPRESAS Y PRESTADA DE FORMADIRECTA, A COLECTIVOS O MEDIANTE COLABORACION CON LASADMINISTRACIONES PUBLICAS. Datos registrales. T
19 de Noviembre de 2009Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Reelecciones. Consejero: BECKER STEFAN. Modificacionesestatutarias. 25. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 25055 , F 147, S 8, H M 79650, I/A 59 ( 6.11.09).