Actos BORME de Culmarex Sa
19 de Diciembre de 2023Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3429 , F 78, S 8,H MU 1091, I/A 82 (12.12.23).
13 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Apo.Manc.: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Apoderado: ANAMARIA JORQUERA SANCHEZ. Apo.Sol.: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Apoderado: ANAMARIA JORQUERA SANCHEZ;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ Datos registrales. T 3429 ,F 78, S 8, H MU 1091, I/A 81 ( 2.12.21).
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PAL ANGELL HANSEN;REGIS PHILIPPE;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Presidente: PAL
15 de Octubre de 2021Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: PESCAVIVA REAL SLU. Datos registrales. T 3429 , F 76, S 8, H MU 1091, I/A 79 (7.10.21).
18 de Enero de 2021Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3429 , F 76, S 8,H MU 1091, I/A 78 (11.01.21).
29 de Octubre de 2020Reelecciones. Consejero: PAL ANGELL HANSEN;REGIS PHILIPPE;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Presidente: PAL ANGELLHANSEN. Vicepresid.: REGIS PHILIPPE. Secretario: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Datosregistrales. T 3429 , F 76, S 8, H MU 1091, I/A 77 (22.10.20).
05 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA DOLORES LOPEZ BELLUGA;AMPARO RAMIREZ PLAZA. Datos registrales. T 2110 , F 220, S8, H MU 1091, I/A 75 (29.01.20).
Nombramientos. Apoderado: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Datos registrales. T 2110 , F 221, S 8, H MU 1091, I/A 76(29.01.20).
28 de Marzo de 2018Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F 220, S 8,H MU 1091, I/A 74 (21.03.18).
31 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7,00 Euros. Desembolsado: 7,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.036.752,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 5.036.752,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9.122.673,00 Euros. Desembolsado: 9.122.673,00 Euros.Resultante Suscrito: 14.159.425,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.159.425,00 Euros. Datos registrales. T 2110 , F 220, S 8, HMU 1091, I/A 73 (24.05.16).
12 de Febrero de 2016Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F 220, S 8,H MU 1091, I/A 72 ( 5.02.16).
02 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BJORN MYRSETH;BJORN MYRSETH;GEOFF SMART;GEOFF SMART. Datos registrales. T 2110 , F220, S 8, H MU 1091, I/A 71 (25.11.15).
15 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO TORRENT BRAVO;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Secretario: ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ. Consejero: ALBERT ROSS BUTLER. Presidente: ALBERT ROSS BUTLER. Consejero: REGIS PHILIPPE.Vicepresid.: REGIS PHILIPPE. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Vicesecret.: GONZALO SOSA ALGUACIL CARRASCO. Secretario:ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Nombramientos. Consejero: PAL ANGELL HANSEN;REGIS PHILIPPE;ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ. Presidente: PAL ANGELL HANSEN. Vicepresid.: REGIS PHILIPPE. Secretario: ANA MARIA JORQUERASANCHEZ. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Datos registrales. T 2110 , F 219, S 8, H MU 1091, I/A 70 ( 2.10.15).
26 de Febrero de 2013Otros conceptos: Modificaci贸n del articulo 22 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 2110 , F 219, S 8, H MU 1091, I/A 69(19.02.13).
04 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: REGIS PHILIPPE. Consejero: GEOFFREY RICHARD SMART. Con.Delegado: GEOFFREYRICHARD SMART. Nombramientos. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Datos registrales. T 2110 , F 219, S 8, H MU 1091, I/A 68(26.06.12).
28 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: CLARA MARIA OLMOS MOLERO. Datos registrales. T 2110 , F 218, S 8, H MU 1091, I/A 67(17.02.12).
22 de Febrero de 2012Nombramientos. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU 1091, I/A 65 (14.02.12).
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GEOFFREY RICHARD SMART. Nombramientos. Consejero: REGIS PHILIPPE. Vicepresid.:REGIS PHILIPPE. Cons.Del.Sol: REGIS PHILIPPE. Datos registrales. T 2110 , F 218, S 8, H MU 1091, I/A 66 (14.02.12).
10 de Febrero de 2012Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F217, S 8, H MU 1091, I/A 64 ( 1.02.12).
07 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: BJORN MYRSETH. Presidente: BJORN MYRSETH. Nombramientos. Consejero: ALBERT ROSSBUTLER. Presidente: ALBERT ROSS BUTLER. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU 1091, I/A 63 (27.01.12).
27 de Octubre de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: COOKE AQUACULTURE INC. Datos registrales. T 2110 , F 217, S8, H MU 1091, I/A 62 (19.10.11).
05 de Septiembre de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MARINE FARMS ASA. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU 1091, I/A 61(25.08.11).
03 de Mayo de 2011Otros conceptos: Mediante escrito fechado el 4 de abril de 2011 por el Vicepresidente y Consejero Delegado Don Geoffrey RichardSmart, con firma legitimada, solicita se haga constar su NIE que es el X-1.228.025-D. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU1091, I/A 60 (20.04.11).
05 de Agosto de 2010Nombramientos. Apoderado: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Datos registrales. T 2110 , F 215, S 8, H MU 1091, I/A 59(27.07.10).
03 de Mayo de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2110 , F 215, S 8, H MU 1091, I/A 57 (22.04.10).
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO TORRENT BRAVO;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Secretario: ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ. Consejero: BJORN MYRSETH;GEOFFREY RICHARD SMART. Con.Delegado: GEOFFREY RICHARDSMART. Presidente: BJORN MYRSETH. Vicepresid.: GEOFFREY RICHARD SMART. Nombramientos. Consejero: BJORNMYRSETH. Presidente: BJORN MYRSETH. Consejero: GEOFFREY RICHARD SMART. Vicepresid.: GEOFFREY RICHARD SMART.Consejero: FERNANDO TORRENT BRAVO;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Secretario: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ.Con.Delegado: GEOFFREY RICHARD SMART. Datos registrales. T 2110 , F 215, S 8, H MU 1091, I/A 58 (22.04.10).