Buscador CIF Logo

Actos BORME Culmarex Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Culmarex Sa

Actos BORME Culmarex Sa - A30106264

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Culmarex Sa con CIF A30106264

馃敊 Perfil de Culmarex Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Culmarex Sa

19 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3429 , F 78, S 8,H MU 1091, I/A 82 (12.12.23).

13 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Apo.Manc.: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Apoderado: ANAMARIA JORQUERA SANCHEZ. Apo.Sol.: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Apoderado: ANAMARIA JORQUERA SANCHEZ;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ Datos registrales. T 3429 ,F 78, S 8, H MU 1091, I/A 81 ( 2.12.21).

20 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: PAL ANGELL HANSEN;REGIS PHILIPPE;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Presidente: PAL

15 de Octubre de 2021
Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: PESCAVIVA REAL SLU. Datos registrales. T 3429 , F 76, S 8, H MU 1091, I/A 79 (7.10.21).

18 de Enero de 2021
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 3429 , F 76, S 8,H MU 1091, I/A 78 (11.01.21).

29 de Octubre de 2020
Reelecciones. Consejero: PAL ANGELL HANSEN;REGIS PHILIPPE;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Presidente: PAL ANGELLHANSEN. Vicepresid.: REGIS PHILIPPE. Secretario: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Datosregistrales. T 3429 , F 76, S 8, H MU 1091, I/A 77 (22.10.20).

05 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: MARIA DOLORES LOPEZ BELLUGA;AMPARO RAMIREZ PLAZA. Datos registrales. T 2110 , F 220, S8, H MU 1091, I/A 75 (29.01.20).

Nombramientos. Apoderado: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Datos registrales. T 2110 , F 221, S 8, H MU 1091, I/A 76(29.01.20).

28 de Marzo de 2018
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F 220, S 8,H MU 1091, I/A 74 (21.03.18).

31 de Mayo de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 7,00 Euros. Desembolsado: 7,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.036.752,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 5.036.752,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 9.122.673,00 Euros. Desembolsado: 9.122.673,00 Euros.Resultante Suscrito: 14.159.425,00 Euros. Resultante Desembolsado: 14.159.425,00 Euros. Datos registrales. T 2110 , F 220, S 8, HMU 1091, I/A 73 (24.05.16).

12 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F 220, S 8,H MU 1091, I/A 72 ( 5.02.16).

02 de Diciembre de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: BJORN MYRSETH;BJORN MYRSETH;GEOFF SMART;GEOFF SMART. Datos registrales. T 2110 , F220, S 8, H MU 1091, I/A 71 (25.11.15).

15 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO TORRENT BRAVO;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Secretario: ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ. Consejero: ALBERT ROSS BUTLER. Presidente: ALBERT ROSS BUTLER. Consejero: REGIS PHILIPPE.Vicepresid.: REGIS PHILIPPE. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Vicesecret.: GONZALO SOSA ALGUACIL CARRASCO. Secretario:ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Nombramientos. Consejero: PAL ANGELL HANSEN;REGIS PHILIPPE;ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ. Presidente: PAL ANGELL HANSEN. Vicepresid.: REGIS PHILIPPE. Secretario: ANA MARIA JORQUERASANCHEZ. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Datos registrales. T 2110 , F 219, S 8, H MU 1091, I/A 70 ( 2.10.15).

26 de Febrero de 2013
Otros conceptos: Modificaci贸n del articulo 22 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 2110 , F 219, S 8, H MU 1091, I/A 69(19.02.13).

04 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: REGIS PHILIPPE. Consejero: GEOFFREY RICHARD SMART. Con.Delegado: GEOFFREYRICHARD SMART. Nombramientos. Con.Delegado: REGIS PHILIPPE. Datos registrales. T 2110 , F 219, S 8, H MU 1091, I/A 68(26.06.12).

28 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apoderado: CLARA MARIA OLMOS MOLERO. Datos registrales. T 2110 , F 218, S 8, H MU 1091, I/A 67(17.02.12).

22 de Febrero de 2012
Nombramientos. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU 1091, I/A 65 (14.02.12).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GEOFFREY RICHARD SMART. Nombramientos. Consejero: REGIS PHILIPPE. Vicepresid.:REGIS PHILIPPE. Cons.Del.Sol: REGIS PHILIPPE. Datos registrales. T 2110 , F 218, S 8, H MU 1091, I/A 66 (14.02.12).

10 de Febrero de 2012
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 2110 , F217, S 8, H MU 1091, I/A 64 ( 1.02.12).

07 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: BJORN MYRSETH. Presidente: BJORN MYRSETH. Nombramientos. Consejero: ALBERT ROSSBUTLER. Presidente: ALBERT ROSS BUTLER. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU 1091, I/A 63 (27.01.12).

27 de Octubre de 2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: COOKE AQUACULTURE INC. Datos registrales. T 2110 , F 217, S8, H MU 1091, I/A 62 (19.10.11).

05 de Septiembre de 2011
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MARINE FARMS ASA. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU 1091, I/A 61(25.08.11).

03 de Mayo de 2011
Otros conceptos: Mediante escrito fechado el 4 de abril de 2011 por el Vicepresidente y Consejero Delegado Don Geoffrey RichardSmart, con firma legitimada, solicita se haga constar su NIE que es el X-1.228.025-D. Datos registrales. T 2110 , F 217, S 8, H MU1091, I/A 60 (20.04.11).

05 de Agosto de 2010
Nombramientos. Apoderado: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Datos registrales. T 2110 , F 215, S 8, H MU 1091, I/A 59(27.07.10).

03 de Mayo de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2110 , F 215, S 8, H MU 1091, I/A 57 (22.04.10).

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO TORRENT BRAVO;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Secretario: ANA MARIAJORQUERA SANCHEZ. Consejero: BJORN MYRSETH;GEOFFREY RICHARD SMART. Con.Delegado: GEOFFREY RICHARDSMART. Presidente: BJORN MYRSETH. Vicepresid.: GEOFFREY RICHARD SMART. Nombramientos. Consejero: BJORNMYRSETH. Presidente: BJORN MYRSETH. Consejero: GEOFFREY RICHARD SMART. Vicepresid.: GEOFFREY RICHARD SMART.Consejero: FERNANDO TORRENT BRAVO;ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ. Secretario: ANA MARIA JORQUERA SANCHEZ.Con.Delegado: GEOFFREY RICHARD SMART. Datos registrales. T 2110 , F 215, S 8, H MU 1091, I/A 58 (22.04.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n