Buscador CIF Logo

Actos BORME Cummins Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cummins Spain Sl

Actos BORME Cummins Spain Sl - B84744317

Tenemos registrados 47 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Cummins Spain Sl con CIF B84744317

馃敊 Perfil de Cummins Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Cummins Spain Sl

03 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 222, S 8, H M 417108,I/A 57 (26.09.23).

22 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: CORNET SOLER MONICA. Nombramientos. Secretario: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO. Datosregistrales. T 34233 , F 221, S 8, H M 417108, I/A 56 (15.12.22).

24 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 221, S 8, H M 417108,I/A 55 (17.11.22).

12 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 221, S 8, H M 417108,I/A 54 ( 7.08.22).

22 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALP HAKAN;EYLES MELANIE;FRETTER MATTHIAS GREGOR;MARTINEZ BERNAL CARLOS.Apo.Manc.: WHIT-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM. Apo.Sol.: ORDU脩A MENDEZ ELISA. Apo.Manc.: ALBERTIMARCO GIOVANNI;GARRUDO HERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: MARTINEZ BERNAL CARLOS;GARRUDOHERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALP HAKAN;EYLES MELANIE;ALBERTI MARCOGIOVANNI;RODRIGUEZ DE LAS HERAS ANGEL;WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;ORDU脩A MENDEZELISA;GARRUDO HERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 34233 , F 219, S 8, H M 417108, I/A 53 (15.11.21).

20 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRETTER MATTHIAS GREGOR. Nombramientos. Consejero: ALBERTI MARCO GIOVANNI.Datos registrales. T 34233 , F 218, S 8, H M 417108, I/A 52 (13.09.21).

02 de Agosto de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ BERNAL CARLOS;GARRUDO HERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T34233 , F 218, S 8, H M 417108, I/A 51 (26.07.21).

30 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;EYLES MELANIE;MUSTEHLIK ISIL;MARTINEZ BERNAL CARLOS.Apo.Manc.: WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;NGOSHI ALOUIS. Apoderado: LOOCKX DOMIENCYRILLE;EYLES MELANIE;FRETTER MATTHIAS GREGOR;MARTINEZ BERNAL CARLOS;WHITE-LEWIS CRENASHARON;NGOSHI ALOUIS;ORDU脩A MENDEZ ELISA;GARRUDO HERNANDEZ FRANCISCO JOSE;ADDISON PAULWILLIAM;MCKENNA ROBERT JAMES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALP HAKAN;EYLES MELANIE;FRETTER MATTHIASGREGOR;MARTINEZ BERNAL CARLOS. Apo.Manc.: WHIT-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM. Apo.Sol.: ORDU脩AMENDEZ ELISA. Apo.Manc.: ALBERTI MARCO GIOVANNI;GARRUDO HERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T34233 , F 216, S 8, H M 417108, I/A 50 (23.03.21).

28 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: ERZGRABER SIMONE. Datos registrales. T 34233 , F 216, S 8, H M 417108, I/A 49 (18.12.20).

18 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 216, S 8, H M 417108,I/A 48 (11.11.20).

14 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOOCKX DOMIEN CYRILLE. Presidente: LOOCKX DOMIEN CYRILLE. Nombramientos.Consejero: ALP HAKAN. Presidente: ALP HAKAN. Datos registrales. T 34233 , F 215, S 8, H M 417108, I/A 47 ( 6.10.20).

13 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 215, S 8, H M 417108,I/A 46 ( 4.12.19).

03 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apoderado: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;EYLES MELANIE;FRETTER MATTHIAS GREGOR;MARTINEZ BERNALCARLOS;WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;NGOSHI ALOUIS;ERZGRABER SIMONE. Nombramientos.Apoderado: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;EYLES MELANIE;FRETTER MATTHIAS GREGOR;MARTINEZ BERNAL CARLOS;WHITE-LEWIS CRENA SHARON;NGOSHI ALOUIS;ORDU脩A MENDEZ ELISA;ERZGRABER SIMONE;GARRUDO HERNANDEZFRANCISCO JOSE;ADDISON PAUL WILLIAM;MCKENNA ROBERT JAMES. Datos registrales. T 34233 , F 213, S 8, H M 417108,I/A 45 (26.09.19).

06 de Junio de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MANGAS MARCOS LUCIA. Apoderado: MANGAS MARCOS LUCIA. Datos registrales. T 34233 , F213, S 8, H M 417108, I/A 44 (30.05.19).

18 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;EYLES MELANIE;FRETTER MATTHIAS GREGOR;MARTINEZ BERNALCARLOS;WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;NGOSHI ALOUIS;MANGAS MARCOS LUCIA;ERZGRABERSIMONE. Datos registrales. T 34233 , F 211, S 8, H M 417108, I/A 43 (11.03.19).

08 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MUSTEHLIK ISIL. Nombramientos. Consejero: FRETTER MATTHIAS GREGOR. Datosregistrales. T 34233 , F 210, S 8, H M 417108, I/A 42 (31.10.18).

24 de Septiembre de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;EYLES MELANIE;MUSTEHLIK ISIL;MARTINEZ BERNAL CARLOS.Apo.Manc.: WHIT-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;DA COSTA MARINA PAULON;NGOSHI ALOUIS;ALCUBILLAALCALA JORGE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;EYLES MELANIE;MUSTEHLIK ISIL;MARTINEZBERNAL CARLOS. Apo.Manc.: WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;NGOSHI ALOUIS. Apo.Man.Soli:MANGAS MARCOS LUCIA. Datos registrales. T 34233 , F 138, S 8, H M 417108, I/A 41 (14.09.18).

21 de Septiembre de 2018
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 36陋 EL PODER OTORGADO A LOOCKX DOMIEN CYRILE,SIENDO LO CORRECTO LOOCKX DOMIEN CYRILLE. SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 36陋 EL PODEROTORGADO A MUSTEHLIKU ISIL, SIENDO LO CORRECTO MUSTEHLIK ISIL. Datos registrales. T 34233 , F 132, S 8, H M417108, I/A 36 (17.01.18).

13 de Septiembre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 138, S 8, H M 417108,I/A 40 ( 6.09.18).

24 de Agosto de 2018
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CUMMINS ENERGY SOLUTIONS BUSINESS IBERIA SL. Datos registrales. T34233 , F 136, S 8, H M 417108, I/A 39 (17.08.18).

22 de Febrero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ VIDRIEROS 9 (SAN FERNANDO DE HENARES). Datos registrales. T 34233 , F 136, S 8, H M417108, I/A 38 (14.02.18).

14 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 136, S 8, H M 417108,I/A 37 ( 7.02.18).

25 de Enero de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: DI PINTO FRANCESCO;CORNET SOLER MONICA. Apo.Sol.: DI PINTO FRANCESCO;EDWARDS

22 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ BERNAL CARLOS;GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO IGNACIO. Nombramientos.Consejero: MUSTEHLIK ISIL;EYLES MELANIE. Apoderado: MARTINEZ BERNAL CARLOS. Datos registrales. T 34233 , F 131, S 8,H M 417108, I/A 35 (14.08.17).

13 de Junio de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;MARTINEZ BERNAL CARLOS;DE LA PLAZA GONZALEZ NOELIA.Apo.Sol.: WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;DA COSTA MARINA PAULON. Nombramientos. Apoderado:LOOCKX DOMIEN CYRILLE;MARTINEZ BERNAL CARLOS;CELESTINA HEYLEN PIERRE;WHITE-LEWIS CRENASHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;DA COSTA MARINA PAULON. Datos registrales. T 34233 , F 129, S 8, H M 417108, I/A 34 (

30 de Diciembre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.999.999,87 Euros. Resultante Suscrito: 4.822.900,68 Euros. Datos registrales. T 34233 , F 129, S8, H M 417108, I/A 33 (21.12.16).

29 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 129, S 8, H M 417108,I/A 32 (20.12.16).

27 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34233 , F 128, S 8, H M 417108,I/A 31 (19.12.16).

13 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BERNAL CARLOS. Datos registrales. T 34233 , F 128, S 8, H M 417108, I/A 30(30.11.16).

08 de Agosto de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO IGNACIO;MARTINEZ BERNALCARLOS;WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;DA COSTA MARINA PAULON. Nombramientos.Apo.Man.Soli: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;MARTINEZ BERNAL CARLOS;DE LA PLAZA GONZALEZ NOELIA. Apo.Sol.: WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;DA COSTA MARINA PAULON. Datos registrales. T 34233 , F 127, S 8, H M417108, I/A 29 (29.07.16).

12 de Abril de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: DI PINTO FRANCESCO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDOIGNACIO. Apo.Manc.: LOOCKX DOMIEN CYRILLE;GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO IGNACIO;MARTINEZ BERNALCARLOS;WHITE-LEWIS CRENA SHARON;ADDISON PAUL WILLIAM;DA COSTA MARINA PAULON. Datos registrales. T 34233 , F126, S 8, H M 417108, I/A 28 ( 4.04.16).

17 de Febrero de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: BARLOW ALLA;DI PINTO FRANCESCO;MARTINEZ BERNAL CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli:LOOCKX DOMIEN CYRILLE;GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO IGNACIO;MARTINEZ BERNAL CARLOS. Datos registrales. T23269 , F 221, S 8, H M 417108, I/A 27 ( 9.02.16).

05 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARLOW ALLA. Presidente: BARLOW ALLA. Nombramientos. Consejero: LOOCKX DOMIENCYRILLE. Presidente: LOOCKX DOMIEN CYRILLE. Datos registrales. T 23269 , F 220, S 8, H M 417108, I/A 26 (27.05.15).

03 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23269 , F 220, S 8, H M 417108,I/A 25 (22.09.14).

29 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23269 , F 220, S 8, H M 417108,I/A 24 (22.09.14).

17 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23269 , F 220, S 8, H M 417108,I/A 23 (10.09.14).

30 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO IGNACIO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ BERNALCARLOS. Datos registrales. T 23269 , F 219, S 8, H M 417108, I/A 21 (22.01.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: BARLOW ALLA;DI PINTO FRANCESCO;MARTINEZ BERNAL CARLOS. Datos registrales. T 23269 , F219, S 8, H M 417108, I/A 22 (22.01.14).

28 de Noviembre de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.180.103,19 Euros. Resultante Suscrito: 822.900,81 Euros. Datos registrales. T 23269 ,F 218, S 8, H M 417108, I/A 20 (16.11.12).

25 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: BIGNELL MICHAEL JAMES. Presidente: BIGNELL MICHAEL JAMES. Nombramientos. Consejero:BARLOW ALLA. Presidente: BARLOW ALLA. Datos registrales. T 23269 , F 218, S 8, H M 417108, I/A 19 (15.10.12).

03 de Abril de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO MIRELES SERGIO MANUEL. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARCIA DEQUEVEDO IGNACIO. Reelecciones. Secretario: CORNET SOLER MONICA. Datos registrales. T 23269 , F 217, S 8, H M 417108,I/A 18 (22.03.12).

22 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VELASCO MIRELES SERGIO MANUEL;EDWARDS ALISON;DI PINTO FRANCESCO. Apoderado:MARTINEZ BERNAL CARLOS;MARTINEZ BERNAL CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BIGNELL MICHAEL JAMES;DIPINTO FRANCESCO;GONZALEZ GARCIA DE QUEVEDO IGNACIO. Datos registrales. T 23269 , F 217, S 8, H M 417108, I/A 17 (9.03.11).

17 de Marzo de 2011
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 23269 , F 216, S 8, H M 417108,I/A 16 ( 7.03.11).

03 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: CODLING SIMON. Presidente: CODLING SIMON. Nombramientos. Consejero: BIGNELL MICHAELJAMES. Presidente: BIGNELL MICHAEL JAMES. Datos registrales. T 23269 , F 216, S 8, H M 417108, I/A 15 (19.04.10).

06 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BERNAL CARLOS. Datos registrales. T 23269 , F 216, S 8, H M 417108, I/A 14(27.01.09).

20 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ BERNAL CARLOS. Datos registrales. T 23269 , F 121, S 8, H M 417108, I/A 13 (9.01.09).

14 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: EDWARDS ALISON. Presidente: EDWARDS ALISON. Nombramientos. Consejero: CODLINGSIMON. Presidente: CODLING SIMON. Datos registrales. T 23269 , F 121, S 8, H M 417108, I/A 12 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n