Actos BORME de Cunicolas Hermi Sl
11 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: TOME MONTES DE CARVALHO PEDRO. Apoderado: MARCOS DEL CASTILLO CELSO. Datosregistrales. T 1458 , F 139, S 8, H VA 10091, I/A 17 (31.03.23).
02 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: RUIZ SAEZ MARINA. Datos registrales. T 1458 , F 139, S 8, H VA 10091, I/A 16 (26.07.17).
25 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: AGUADERO AGUILAR CARLOS. Datos registrales. T 1458 , F 139, S 8, H VA 10091, I/A 15(18.04.17).
05 de Octubre de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: CESAR MIGUEL CASADO SL. Datos registrales. T 1458 , F 138, S 8, H VA 10091,I/A 14 (28.09.15).
13 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN CASADO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 1458 , F 138, S 8, H VA 10091, I/A 13 (6.02.15).
04 de Noviembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 14.393,93 Euros. Resultante Suscrito: 18.000,00 Euros. Datos registrales. T 1458 , F 138, S 8, HVA 10091, I/A 12 (28.10.14).
09 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: RUIZ SAEZ MARINA. Datos registrales. T 827 , F 94, S 8, H VA 10091, I/A 11 ( 2.05.14).
28 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: NEGREAN GABRIELA. Datos registrales. T 827 , F 94, S 8, H VA 10091, I/A 10 (17.12.10).
15 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN CASADO MARIA DEL PILAR;NEGREAN GABRIELA. Datos registrales. T 827 , F 94, S 8,H VA 10091, I/A 9 ( 4.06.10).
07 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: MARCOS DEL CASTILLO CELSO. Apo.Sol.: MARCOS DEL CASTILLO CELSO. Datos registrales. T827 , F 94, S 8, H VA 10091, I/A 8 (26.05.10).