Actos BORME de Cupa Innovacion Sl
01 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER;FERNANDEZ GARCIA AURELIANO;RODRIGUEZ GAYOSOULPIANO. Presidente: RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO. Vicepresid.: FERNANDEZ GARCIA AURELIANO. Secretario: FERNANDEZFERNANDEZ JAVIER. Cons.Del.Sol: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER;RODRIGUEZ GAYOSO ULPIANO. Nombramientos.Adm. Unico: CUPIRE PADESA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administrador 煤nico. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 148, S 8, H PO 40221, I/A 16 (24.11.14).
03 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: TRINCADO FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 147, S 8, H PO 40221, I/A15 (27.08.13).
27 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 103.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 163.000,00 Euros. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 147,S 8, H PO 40221, I/A 14 (18.01.12).
25 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA PAZO EDUARDO ALEJANDRO. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 147, S 8, H PO 40221,I/A 13 (12.08.11).
31 de Marzo de 2011Revocaciones. Apoderado: GOMEZ RUIZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 146, S 8, H PO 40221, I/A 12(18.03.11).
22 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: BOUZON RIVAS ALBERTO. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 146, S 8, H PO 40221, I/A 11 (8.02.11).
24 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: MONTERO ROLDAN EVA. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 146, S 8, H PO 40221, I/A 10(12.02.10).
22 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: BOUZON RIVAS ALBERTO. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 146, S 8, H PO 40221, I/A 9 (7.04.09).
09 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: TRINCADO FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 3203, L 3203, F 145, S 8, H PO 40221, I/A8 (23.02.09).