Actos BORME de Cuperal Sl
20 de Enero de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.071.290,30 Euros. Resultante Suscrito: 8.073.076,74 Euros. Datos registrales. T 489 , F 195, S 8,H SA 1321, I/A 18 ( 9.01.23).
31 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: CRESPO VILLORIA BEATRIZ. Vicepresid.: CRESPO SANCHEZ NARCISO. Con.Delegado: CRESPOSANCHEZ NARCISO. Nombramientos. Presidente: CRESPO SANCHEZ NARCISO. Vicepresid.: CRESPO VILLORIA BEATRIZ.Con.Delegado: CRESPO VILLORIA BEATRIZ. Datos registrales. T 46 , F 147, S 8, H SA 1321, I/A 16 (22.12.21).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.651.415,78 Euros. Resultante Suscrito: 5.001.786,44 Euros. Datos registrales. T 489 , F 195, S 8,H SA 1321, I/A 17 (22.12.21).
17 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: F. BRITO AUDITORES SL. Datos registrales. T 46 , F 147, S 8, H SA 1321, I/A 15 (29.11.21).
15 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO VILLORIA ANA-ISABEL. Secretario: CRESPO VILLORIA ANA-ISABEL. Consejero:CRESPO VILLORIA BEATRIZ;VILLORIA RAMOS MERCEDES. Presidente: VILLORIA RAMOS MERCEDES. Con.Delegado:VILLORIA RAMOS MERCEDES. Nombramientos. Consejero: CRESPO VILLORIA BEATRIZ. Presidente: CRESPO VILLORIABEATRIZ. Consejero: CRESPO SANCHEZ NARCISO. Vicepresid.: CRESPO SANCHEZ NARCISO. Consejero: CRESPO VILLORIAANA-ISABEL. Secretario: CRESPO VILLORIA ANA-ISABEL. Consejero: VILLORIA RAMOS MERCEDES. Con.Delegado: CRESPOSANCHEZ NARCISO. Datos registrales. T 46 , F 146, S 8, H SA 1321, I/A 12 ( 7.01.21).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.554.294,18 Euros. Resultante Suscrito: 3.350.370,66Euros. Datos registrales. T 46 , F 146, S 8, H SA 1321, I/A 13 ( 7.01.21).
Cambio de domicilio social. AVDA DE LA ILUSTRACION 2 - POLIGONO AGROALIMENTARI (VITIGUDINO). Datos registrales. T46 , F 147, S 8, H SA 1321, I/A 14 ( 7.01.21).
03 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO SANCHEZ NARCISO. Presidente: CRESPO SANCHEZ NARCISO. Con.Delegado:CRESPO SANCHEZ NARCISO. Nombramientos. Consejero: VILLORIA RAMOS MERCEDES. Presidente: VILLORIA RAMOSMERCEDES. Con.Delegado: VILLORIA RAMOS MERCEDES. Datos registrales. T 46 , F 145, S 8, H SA 1321, I/A 11 (28.03.19).
08 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: BRITO CARNICERO FELIPE. Aud.Supl.: BRITO GONZALEZ FELIPE. Datos registrales. T 46 , F 145, S8, H SA 1321, I/A 10 (27.12.18).
15 de Septiembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.735.976,48 Euros. Resultante Suscrito: 1.796.076,48 Euros. Datos registrales. T 46 , F 141, S 8,H SA 1321, I/A 9 ( 6.09.17).