Actos BORME de Cuscon Sa
13 de Diciembre de 2023Cambio de domicilio social. CL COLON Num.408 P.2 PTA.2 (TERRASSA). Datos registrales. T 46455 , F 74, S 8, H B 12439, I/A30 ( 1.12.23).
01 de Agosto de 2023Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 24.1, 24.5, 25.2, 25.6 Y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 46455 , F 73, S 8, H B 12439, I/A 29 (24.07.23).
12 de Junio de 2023Revocaciones. CONS. DELEG.: CUSIDO CODINA JOSEP. Nombramientos. CONSEJERO: CUSIDO SIMON IGNACIO.PRESIDENTE: CUSIDO SIMON IGNACIO. CONSEJERO: CODINA TOMAS MARIA DOLORS. VICEPRESIDEN: CODINA TOMASMARIA DOLORS. CONSEJERO: CUSIDO CODINA IGNASI;CUSIDO CODINA FERRAN. CONS. DELEG.: CUSIDO CODINAFERRAN. CONSEJERO: CUSIDO CODINA ANTONI;CUSIDO CODINA JOSEP. Datos registrales. T 46455 , F 72, S 8, H B 12439,I/A 28 ( 1.06.23).
18 de Febrero de 2019Revocaciones. AUDIT.CUENT.: AUDRIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 46455 , F 72, S 8, H B 12439,I/A 27 ( 8.02.19).
31 de Diciembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.779.989,50 Euros. Desembolsado: 3.779.989,50 Euros. Resultante Suscrito: 12.565.467,70 Euros.Resultante Desembolsado: 12.565.467,70 Euros. Datos registrales. T 46455 , F 71, S 8, H B 12439, I/A 25 (20.12.18).
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDRIA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP. Datos registrales. T 46455 , F 72, S 8, H B 12439,I/A 26 (20.12.18).
05 de Julio de 2018Nombramientos. CONSEJERO: CUSIDO SIMON IGNACIO. PRESIDENTE: CUSIDO SIMON IGNACIO. CONSEJERO: CODINATOMAS MARIA DOLORS. VICEPRESIDEN: CODINA TOMAS MARIA DOLORS. CONSEJERO: CUSIDO CODINA IGNASI;CUSIDOCODINA FERRAN. CONS. DELEG.: CUSIDO CODINA FERRAN. CONSEJERO: CUSIDO CODINA JOSEP. CONS. DELEG.: CUSIDOCODINA JOSEP. CONSEJERO: CUSIDO CODINA ANTONI. SECR.NO CONS: GIMENO BOU JOAN MARIA. Datos registrales. T39930 , F 160, S 8, H B 12439, I/A 24 (27.06.18).
25 de Marzo de 2013Revocaciones. CONSEJERO: CUSIDO SIMON IGNACIO. PRESIDENTE: CUSIDO SIMON IGNACIO. CONSEJERO: CODINATOMAS MARIA DOLORES. VICEPRESIDEN: CODINA TOMAS MARIA DOLORES. CONSEJERO: CUSIDO CODINA FERRAN.CONS. DELEG.: CUSIDO CODINA FERRAN. CONSEJERO: CUSIDO CODINA ANTONI;CUSIDO CODINA JOSEP. CONS. DELEG.:CUSIDO CODINA JOSEP. CONSEJERO: CUSIDO CODINA IGNASI. Nombramientos. CONSEJERO: CUSIDO SIMON IGNASI.PRESIDENTE: CUSIDO SIMON IGNASI. CONSEJERO: CODINA TOMAS MARIA DOLORS. VICEPRESIDEN: CODINA TOMASMARIA DOLORS. CONSEJERO: CUSIDO CODINA IGNASI;CUSIDO CODINA FERRAN. CONS. DELEG.: CUSIDO CODINAFERRAN. CONSEJERO: CUSIDO CODINA ANTONI;CUSIDO CODINA JOSEP. CONS. DELEG.: CUSIDO CODINA JOSEP. Datosregistrales. T 39930 , F 158, S 8, H B 12439, I/A 23 (13.03.13).
31 de Enero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.000.004,00 Euros. Desembolsado: 1.000.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.785.478,20 Euros.Resultante Desembolsado: 8.785.478,20 Euros. Datos registrales. T 39930 , F 157, S 8, H B 12439, I/A 22 (19.01.11).
10 de Septiembre de 2010Modificaciones estatutarias. ART.24(apartado 5).-RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES. Datos registrales. T 39930 , F157, S 8, H B 12439, I/A 21 (31.08.10).
26 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.849.998,20 Euros. Desembolsado: 1.849.998,20 Euros. Resultante Suscrito: 7.785.474,20 Euros.Resultante Desembolsado: 7.785.474,20 Euros. Datos registrales. T 39930 , F 156, S 8, H B 12439, I/A 20 (13.01.10).
05 de Febrero de 2009Nombramientos. CONSEJERO: CUSIDO SIMON IGNACIO. PRESIDENTE: CUSIDO SIMON IGNACIO. CONSEJERO: CODINATOMAS MARIA DOLORES. VICEPRESIDEN: CODINA TOMAS MARIA DOLORES. CONSEJERO: CUSIDO CODINA FERRAN.CONS. DELEG.: CUSIDO CODINA FERRAN. CONSEJERO: CUSIDO CODINA ANTONI;CUSIDO CODINA JOSEP. CONS. DELEG.:CUSIDO CODINA JOSEP. CONSEJERO: CUSIDO CODINA IGNASI. SECR.NO CONS: GIMENO BOU JUAN MARIA. Datosregistrales. T 39930 , F 154, S 8, H B 12439, I/A 19 (23.01.09).