Actos BORME de Cuyam Sl
04 de Abril de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 124.734,40 Euros. Resultante Suscrito: 480.757,20 Euros. Datos registrales. T 28975 , F 34, S 8, HM 293, I/A 30 (28.03.22).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: VALDEMIRA SL. P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T28975 , F 36, S 8, H M 293, I/A 31 (28.03.22).
08 de Septiembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 253.321,60 Euros. Resultante Suscrito: 356.022,80 Euros. Datos registrales. T 28975 , F 34, S 8, HM 293, I/A 29 ( 1.09.21).
18 de Septiembre de 2019Cambio de domicilio social. C/ NURIA NUMERO 59, 2潞 (MADRID). Datos registrales. T 28975 , F 34, S 8, H M 293, I/A 28(11.09.19).
25 de Agosto de 2017Nombramientos. Auditor: MORISON AC SLP. Datos registrales. T 28975 , F 33, S 8, H M 293,293 , I/ 27 .(17.08.17).
24 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL;CAMPOS CASTA脩O EDUARDO. Nombramientos. Apoderado: BANUSGUTIERREZ RAFAEL ANGEL;FRESNILLO DE LEON OSCAR. Cambio de domicilio social. TRVA DE COSTA BRAVA NUMERO 6,7潞 C (MADRID). Datos registrales. T 28975 , F 32, S 8, H M 293,293 , I/ 26 .(16.12.15).
14 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: BANUS GUTIERREZ MANUEL. Datos registrales. T 28975 , F 32, S 8, H M 293,293 , I/ 25 .( 6.04.15).
03 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.:BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUS GUTIERREZ RAFAEL. Datos registrales. T 28975 , F 30, S 8, H M 293,293 , I/ 23.(26.01.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ ANGEL. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ ANGEL. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZRAFAEL. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUSGUTIERREZ GONZALO. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ GONZALO. Nombramientos. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZRAFAEL;CAMPOS CASTA脩O EDUARDO. Datos registrales. T 28975 , F 31, S 8, H M 293,293 , I/ 24 .(26.01.15).
26 de Febrero de 2013Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28975 , F 30, S 8, H M 293,293 ,I/ 22 .(18.02.13).
07 de Julio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ ANGEL. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ ANGEL. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZRAFAEL. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ RAFAEL. Apo.Sol.: BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ MANUEL;BANUSGUTIERREZ GONZALO. Apo.Manc.: BANUS GUTIERREZ GONZALO. Datos registrales. T 11646 , F 199, S 8, H M 293,293 , I/ 21.(27.06.11).
06 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GUTIERREZ FERNANDEZ CELIA;BANUS GUTIERREZ JUAN. Nombramientos. Adm. Mancom.:BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ MANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 11646 , F 199, S 8, H M 293,293 , I/ 19.(24.06.11).
Revocaciones. Apoderado: CORRAL LOPEZ JOSE;BANUS GUTIERREZ JUAN;BANUS GUTIERREZ GONZALO;BANUSGUTIERREZ MANUEL;BANUS ALEIXANDRE ALVARO. Datos registrales. T 11646 , F 199, S 8, H M 293,293 , I/ 20 .(24.06.11).
15 de Enero de 2010Nombramientos. Auditor: MORISON AC SL. Datos registrales. T 11646 , F 199, S 8, H M 293,293 , I/ 18 .( 4.01.10).
06 de Abril de 2009Revocaciones. Apoderado: SERRANO RODRIGUEZ HIPOLITO. Datos registrales. T 11646 , F 199, S 8, H M 293,293 , I/ 17.(26.03.09).