Actos BORME de Cvne Bilbao Sociedad Limitada
28 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: HERRERO AGAPITO ALBERTO;GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCOJAVIER;HERRERO AGAPITO ALBERTO;GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCO JAVIER;ARANCONGARCIA CYNTIA. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCOJAVIER;URRUTIA YBARRA MARIA DEL DULCE NOMBRE;SANZ LARREA I脩AKI;LEZANA PEREZ RAQUEL;GUERRERO GILPEDRO;HERRERO AGAPITO ALBERTO;ARANCON GARCIA CYNTIA;PARRA AGUIRRE MARIELA DEL CARMEN;RIVAS MORRASBEATRIZ;DE MIGUEL MATUTE MARIA DEL PINO;GRANERO GIRON JAVIER;AMATRIA SOLA MARIA AMAIA. Datos registrales. T
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: URRUTIA YBARRA VICTOR. Nombramientos. Adm. Unico: COMPA脩IA VINICOLA DEL NORTEDE ESPA脩A SOCIEDAD ANO. Datos registrales. T 5721 , F 202, S 8, H BI 62494, I/A 12 (19.04.22).
14 de Mayo de 2020Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ FRIAS MARIA DE LAS NIEVES. Datos registrales. T 5721 , F 196, S 8, H BI 62494, I/A 10 (4.05.20).
23 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: ARANCON GARCIA CYNTIA. Datos registrales. T 5382 , F 175, S 8, H BI 62494, I/A 9 (15.11.17).
29 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: SOLANS AREIZAGA JAVIER;GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCOJAVIER;ISPIZUA ALDAMIZ JAVIER. Datos registrales. T 5382 , F 175, S 8, H BI 62494, I/A 8 (21.06.17).
05 de Octubre de 2016Modificaci贸n de poderes. Apoderado: GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCO JAVIER;MARTINEZFRIAS MARIA DE LAS NIEVES. Datos registrales. T 5382 , F 174, S 8, H BI 62494, I/A 7 (27.09.16).
27 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: HERRERO AGAPITO ALBERTO;GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCOJAVIER;ISPIZUA ALDAMIZ JAVIER;MARTINEZ FRIAS MARIA DE LAS NIEVES. Datos registrales. T 5382 , F 172, S 8, H BI 62494,I/A 6 (19.04.16).
27 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5382, F 172, S 8, H BI 62494, I/A 5 (18.11.15).
12 de Diciembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 160.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 410.000,00 Euros. Datos registrales. T 5382 , F 171, S 8, HBI 62494, I/A 4 (27.11.14).
18 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: HERRERO AGAPITO ALBERTO. Datos registrales. T 5382 , F 170, S 8, H BI 62494, I/A 3 (10.06.14).
09 de Julio de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 20.06.13. Objeto social: compraventa, distribuci贸n y comercializaci贸n de vinos y otrasbebidas alcoholicas. Domicilio: C/ LARRONDO GOIKO N潞 3, PABELLONES 6 Y 7 (LOIU). Capital: 250.000,00 Euros.Nombramientos. Adm. Unico: URRUTIA YBARRA VICTOR. Datos registrales. T 5382 , F 166, S 8, H BI 62494, I/A 1 (27.06.13).
Nombramientos. Apoderado: SOLANS AREIZAGA JAVIER;GONZALEZ ESTANDIA GAIZKA;MU脩OZ MUGUIRO FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 5382 , F 169, S 8, H BI 62494, I/A 2 (27.06.13).