Actos BORME de Cx Ebip Agreement Sl
12 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GENETRIX SL. Representan: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA. Revocaciones. Apoderado:LAPE脩A BOTIJA MARIA LOURDES;GOMEZ-ALMANSA PLAZA ANTONIO;LAPE脩A BOTIJA MARIA LOURDES. Nombramientos.Liquidador M: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA;SANTANA GONZALEZ DOMINGO. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 25312 , F 163, S 8, H M 455826, I/A 12 ( 4.12.18).
28 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: DEL CASTILLO TAMAYO JUAN CARLOS. Nombramientos. Representan: GARMENDIAMENDIZABAL CRISTINA. Datos registrales. T 25312 , F 163, S 8, H M 455826, I/A 11 (17.12.15).
18 de Febrero de 2015Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GENETRIX SL. Datos registrales. T 25312 , F 163, S 8, H M455826, I/A 10 (10.02.15).
21 de Mayo de 2014Cambio de domicilio social. C/ SANTIAGO GRISOLIA 2, LOCAL 15 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 25312 , F 162, S 8, HM 455826, I/A 9 (12.05.14).
21 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: DE LA HUERTA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. Nombramientos. Representan: DEL CASTILLOTAMAYO JUAN CARLOS. Datos registrales. T 25312 , F 162, S 8, H M 455826, I/A 8 (10.05.13).
21 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ MARTINEZ EDUARDO. Nombramientos. Representan: DE LA HUERTA MARTINEZMARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 25312 , F 162, S 8, H M 455826, I/A 7 (11.01.11).