Buscador CIF Logo

Actos BORME Cytognos Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Cytognos Sl

Actos BORME Cytognos Sl - B37319225

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Salamanca para Cytognos Sl con CIF B37319225

馃敊 Perfil de Cytognos Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Salamanca

Actos BORME de Cytognos Sl

17 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: NARVAEZ DE LA PE脩A VICTOR. Apo.Sol.: NARVAEZ DE LA PE脩A VICTOR;CHOCRONYOHANA;NARVAEZ DE LA PE脩A VICTOR. Datos registrales. T 405 , F 9, S 8, H SA 5070, I/A 39 ( 4.04.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN BAQUERO JOSE-LUIS;FLORES MARTINEZ RAQUEL;HERRERO GOMEZ CARLOS-JOSE.Datos registrales. T 405 , F 9, S 8, H SA 5070, I/A 40 ( 4.04.23).

10 de Abril de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 405 , F 9, S 8, H SA 5070, I/A 38 (29.03.23).

17 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MILLAN BAQUERO JOSE-LUIS. Datos registrales. T 404 , F 223, S 8, H SA 5070, I/A 37 ( 8.03.23).

10 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MORALES OLIVERA FERNANDO. Secretario: MORALES OLIVERA FERNANDO. Consejero: JULIANSOMOYA HORACIO. Nombramientos. Consejero: LUINO ALESSANDRO;CARMONA MARISCAL MERCEDES. Secretario:CARMONA MARISCAL MERCEDES. Datos registrales. T 404 , F 223, S 8, H SA 5070, I/A 36 ( 1.02.23).

25 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MILLAN BAQUERO JOSE-LUIS;NARVAEZ DE LA PE脩A VICTOR. Apo.Sol.: NARVAEZ DE LAPE脩A VICTOR;CHOCRON YOHANA;NARVAEZ DE LA PE脩A VICTOR;GONZALEZ CARRERA SERGIO;RAMAS MATA LAURA.Datos registrales. T 404 , F 210, S 8, H SA 5070, I/A 34 (18.11.22).

Revocaciones. Apoderado: MARTIN DE LARA FERNANDO. Apo.Sol.: MARTIN DE LARA FERNANDO;MARTIN DE LARAFERNANDO. Apoderado: MARTIN DE LARA FERNANDO. Datos registrales. T 404 , F 223, S 8, H SA 5070, I/A 35 (18.11.22).

07 de Julio de 2022
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Datos registrales. T 404 , F 209, S 8, H SA 5070, I/A 33(27.06.22).

13 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: BENSADON BELICHA JORGE;MARTIN AYUSO MARTA. Apo.Sol.: BENSADON BELICHAJORGE;BENSADON BELICHA JORGE. Datos registrales. T 404 , F 209, S 8, H SA 5070, I/A 32 ( 4.05.22).

31 de Marzo de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BD SWITZERLAND S.A R.L. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VAZQUEZ CALOMARIA TERESA. Consejero: BENSADON BELICHA JORGE. Presidente: BENSADON BELICHA JORGE. Consejero: JIMENEZRODRIGUEZ JUAN;VITRO SA;JUDEL PRIETO FRANCISCO-JAVIER;GUERRERO IGEA FELIX-MANUEL. Vicepresid.: GUERREROIGEA FELIX-MANUEL. Nombramientos. Consejero: MORALES OLIVERA FERNANDO. Secretario: MORALES OLIVERAFERNANDO. Consejero: DE RYCKER PETER E.M. Presidente: DE RYCKER PETER E.M. Consejero: JULIAN SOMOYA HORACIO.VsecrNoConsj: PASTOR CABALLERO CECILIA. Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 21.- Funcionamiento del Consejo deAdministraci贸n Cuando la administraci贸n recaiga en un Consejo de Administraci贸n, se observar谩n las reglas siguientes: a) El Consejode Administraci贸n ser谩 convocado por su Presidente o el que haga sus veces. Los Consejeros que constituyan al menos un. Datosregistrales. T 404 , F 182, S 8, H SA 5070, I/A 31 (25.03.22).

25 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 404 , F 182, S 8, H SA 5070, I/A 30 (17.11.21).

18 de Septiembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: OSES MUGICA NURIA. Vicepresid.: OSES MUGICA NURIA. Nombramientos. Consejero:GUERRERO IGEA FELIX-MANUEL. Datos registrales. T 404 , F 111, S 8, H SA 5070, I/A 28 ( 3.09.20).

Nombramientos. Vicepresid.: GUERRERO IGEA FELIX-MANUEL. Datos registrales. T 404 , F 182, S 8, H SA 5070, I/A 29 (3.09.20).

07 de Agosto de 2020
Ampliaci贸n de capital. Capital: 102,34 Euros. Resultante Suscrito: 4.689,58 Euros. Datos registrales. T 404 , F 111, S 8, H SA5070, I/A 27 (29.07.20).

04 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMRAN COHEN DONNA. Nombramientos. Consejero: JUDEL PRIETO FRANCISCO-JAVIER.Datos registrales. T 404 , F 111, S 8, H SA 5070, I/A 26 (28.05.20).

14 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTIN DE LARA FERNANDO. Datos registrales. T 404 , F 110, S 8, H SA 5070, I/A 25 ( 6.02.19).

07 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 404 , F 110, S 8, H SA 5070, I/A 24 (26.11.18).

07 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENSADON BELICHA JORGE. Presidente: BENSADON BELICHA JORGE. Consejero: FERNANDEZENRIQUEZ ANTONIO;CLAVE MAYOR SA SGECR. SecreNoConsj: ETXALAR ELIZAINTZIN JUAN-JOSE. Nombramientos.Consejero: BENSADON BELICHA JORGE. Presidente: BENSADON BELICHA JORGE. Consejero: OSES MUGICA NURIA.Vicepresid.: OSES MUGICA NURIA. SecreNoConsj: VAZQUEZ CALO MARIA TERESA. Consejero: JIMENEZ RODRIGUEZJUAN;AMRAN COHEN DONNA;VITRO SA. Datos registrales. T 404 , F 55, S 8, H SA 5070, I/A 22 (29.08.18).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 349,16 Euros. Resultante Suscrito: 4.587,24 Euros. Datos registrales. T 404 , F 110, S 8,H SA 5070, I/A 23 (29.08.18).

03 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ABAIGAR DOMINGUEZ ALVARO. VsecrNoConsj: OBANOS MUGUIRO MARIA.Nombramientos. SecreNoConsj: ETXALAR ELIZAINTZIN JUAN-JOSE. Datos registrales. T 404 , F 55, S 8, H SA 5070, I/A 21(18.02.16).

01 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 180,60 Euros. Resultante Suscrito: 4.936,40 Euros. Datos registrales. T 404 , F 54, S 8, H SA 5070,I/A 20 (15.01.16).

08 de Enero de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: BENSADON BELICHA JORGE;MARTIN DE LARA FERNANDO. Modificaci贸n de poderes. Apoderado:BENSADON BELICHA JORGE. Datos registrales. T 404 , F 54, S 8, H SA 5070, I/A 19 (21.12.12).

21 de Octubre de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: BENSADON BELICHA JORGE;MARTIN DE LARA FERNANDO. Datos registrales. T 404 , F 53, S 8, HSA 5070, I/A 15 (30.09.11).

15 de Junio de 2011
Ampliaci贸n de capital. Capital: 529,76 Euros. Resultante Suscrito: 4.755,80 Euros. Datos registrales. T 404 , F 52, S 8, H SA 5070,I/A 14 (25.05.11).

18 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: MARTIN DE LARA FERNANDO. Datos registrales. T 404 , F 51, S 8, H SA 5070, I/A 13 (29.10.10).

16 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BENSADON BELICHA JORGE. Revocaciones. Apoderado: RUBIO FIDALGO MARIA CANDIDAMARGARITA;JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN;BUSTAMANTE GALLARDO PABLO;BUSTAMANTE GALLARDO PABLO.Nombramientos. SecreNoConsj: PALACIOS APARICIO CARLOS ANTONIO. VsecrNoConsj: OBANOS MUGUIRO MARIA.Consejero: BENSADON BELICHA JORGE. Presidente: BENSADON BELICHA JORGE. Consejero: FERNANDEZ ENRIQUEZANTONIO;CLAVE MAYOR SA SGECR. Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.216,04 Euros. Resultante Suscrito: 4.226,04 Euros.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Otrosconceptos: MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 158 , F 15, S 8, H SA 5070, I/A 9 (26.02.10).

Nombramientos. Apoderado: BENSADON BELICHA JORGE. Datos registrales. T 404 , F 49, S 8, H SA 5070, I/A 10 (26.02.10).

Nombramientos. Apoderado: MARTIN AYUSO MARTA. Datos registrales. T 404 , F 50, S 8, H SA 5070, I/A 11 (26.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n