Buscador CIF Logo

Actos BORME Daf Vehiculos Industriales Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Daf Vehiculos Industriales Sa

Actos BORME Daf Vehiculos Industriales Sa - A81253916

Tenemos registrados 40 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Daf Vehiculos Industriales Sa con CIF A81253916

🔙 Perfil de Daf Vehiculos Industriales Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Daf Vehiculos Industriales Sa

27 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 67, S 8, H M 159291, I/A 83 (20.11.23).

03 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZINK RICHARD-DANIEL-THEODORUS. Presidente: ZINK RICHARD-DANIEL-THEODORUS.Nombramientos. Consejero: BOSMANS BART MARINA HERMAN LEO JOHANNA. Presidente: BOSMANS BART MARINAHERMAN LEO JOHANNA. Datos registrales. T 26096 , F 66, S 8, H M 159291, I/A 82 (26.09.23).

25 de Octubre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: HAYGOOD KEVIN DANIEL. Nombramientos. Consejero: HENDRIKUS PETRUS MICHIELJOHANNES. Datos registrales. T 26096 , F 66, S 8, H M 159291, I/A 81 (18.10.22).

12 de Agosto de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 66, S 8, H M 159291, I/A 80 ( 5.08.22).

16 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 66, S 8, H M 159291, I/A 79 ( 9.12.21).

16 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN GEEL JOHANNES THEODORUS ANTONIUS. Nombramientos. Consejero: VAN VEENEELCO ANTHONIE. Datos registrales. T 26096 , F 65, S 8, H M 159291, I/A 78 ( 9.04.21).

05 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOSMANS BART MARINA HERMAN LEO JOHANNA. Nombramientos. Consejero: HAYGOODKEVIN DANIEL. Reelecciones. Consejero: ZINK RICHARD-DANIEL-THEODORUS. Presidente: ZINK RICHARD-DANIEL-THEODORUS. Datos registrales. T 26096 , F 65, S 8, H M 159291, I/A 77 (25.03.21).

19 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 65, S 8, H M 159291, I/A 76 ( 9.10.20).

03 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 26096 , F 64, S 8, H M 159291,I/A 75 (27.01.20).

09 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 64, S 8, H M 159291, I/A 74 ( 2.10.19).

01 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ ARDAVIN FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: PEREZ ROMERO JAVIER. Datosregistrales. T 26096 , F 63, S 8, H M 159291, I/A 73 (24.09.19).

02 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ ARDAVIN JAVIER. Con.Delegado: SANCHEZ ARDAVIN JAVIER. Nombramientos.Consejero: VAN GEEL JOHANNES THEODORUS ANTONIUS;BOSMANS BART MARINA HERMAN LEO JOHANNA. Datosregistrales. T 26096 , F 63, S 8, H M 159291, I/A 72 (26.07.19).

14 de Agosto de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 63, S 8, H M 159291, I/A 71 ( 5.08.18).

18 de Julio de 2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: VAN GEEL JOHANNES THEODORUS ANTONIUS. Datos registrales. T26096 , F 57, S 8, H M 159291, I/A 556 m (10.07.18).

15 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 62, S 8, H M 159291, I/A 70 ( 8.09.17).

23 de Agosto de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 62, S 8, H M 159291, I/A 69 (16.08.17).

01 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 62, S 8, H M 159291, I/A 68 (23.11.15).

19 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ ROMERO JAVIER. Apo.Manc.: MORALES CAS ANTONIO;SANCHEZ ARDAVINJAVIER;EIZAGUIRRE PUJOL ELISABET. Datos registrales. T 26096 , F 61, S 8, H M 159291, I/A 67 (12.11.15).

29 de Octubre de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ PEREZ RUTH. Datos registrales. T 26096 , F 61, S 8, H M 159291, I/A 66 (20.10.15).

22 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BONSEN RONNY BARTHOLOMEUS. Presidente: BONSEN RONNY BARTHOLOMEUS.Nombramientos. Consejero: ZINK RICHARD-DANIEL-THEODORUS. Presidente: ZINK RICHARD-DANIEL-THEODORUS. Datosregistrales. T 26096 , F 61, S 8, H M 159291, I/A 65 (14.09.15).

18 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apoderado: VAN KEULEN AUGUST GERALD MARTIJN;ROMANO TERRADEZ GREGORIO;ROMANO TERRADEZGREGORIO;ROMANO TERRADEZ GREGORIO. Apo.Sol.: ROMANO TERRADEZ GREGORIO. Apo.Manc.: VAZQUEZ VALLEPATRICIA;IGLESIAS CARRIZO JAVIER. Apo.Man.Soli: VAZQUEZ VALLE PATRICIA. Datos registrales. T 26096 , F 60, S 8, H M159291, I/A 63 (10.02.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: EIZAGUIRRE PUJOL ELISABET;MORALES CAS ANTONIO. Apo.Sol.: EIZAGUIRRE PUJOLELISABET;EIZAGUIRRE PUJOL ELISABET. Datos registrales. T 26096 , F 60, S 8, H M 159291, I/A 64 (10.02.15).

11 de Agosto de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 59, S 8, H M 159291, I/A 62 ( 1.08.14).

13 de Febrero de 2014
Reelecciones. Consejero: SANCHEZ ARDAVIN FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: SANCHEZ ARDAVIN FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 26096 , F 59, S 8, H M 159291, I/A 61 ( 5.02.14).

10 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 59, S 8, H M 159291, I/A 60 ( 2.10.13).

08 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apoderado: MORALES CAS ANTONIO. Datos registrales. T 26096 , F 58, S 8, H M 159291, I/A 59 (31.07.13).

16 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ VALLE PATRICIA;IGLESIAS CARRIZO JAVIER;PEREZ PEREZ RUTH. Nombramientos.Apo.Man.Soli: MORALES CAS ANTONIO;VAZQUEZ VALLE PATRICIA;PEREZ PEREZ RUTH. Datos registrales. T 26096 , F 57, S8, H M 159291, I/A 58 ( 8.05.13).

20 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: COWARD CHARLES CORWIN. VsecrNoConsj: GARCIA-OCHOA MAYOR DAVID. Nombramientos.SecreNoConsj: DIAZ HIDALGO JUAN EUGENIO. VsecrNoConsj: CRUZ-VILLALON GARCIA DIEGO. Datos registrales. T 26096 , F57, S 8, H M 159291, I/A 57 ( 6.11.12).

27 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 57, S 8, H M 159291, I/A 56 (14.08.12).

31 de Julio de 2012
Reelecciones. Consejero: VAN GEEL JOHANNES THEODORUS ANTONIUS;BONSEN RONNY BARTHOLOMEUS. Presidente:BONSEN RONNY BARTHOLOMEUS. Datos registrales. T 26096 , F 57, S 8, H M 159291, I/A 55 (19.07.12).

15 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ VALLE PATRICIA;IGLESIAS CARRIZO JAVIER;CASTRO LOPES JOSE DINIS.Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ VALLE PATRICIA;IGLESIAS CARRIZO JAVIER;PEREZ PEREZ RUTH. Datos registrales.T 26096 , F 55, S 8, H M 159291, I/A 54 ( 1.12.11).

05 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 55, S 8, H M 159291, I/A 53 (23.11.11).

08 de Agosto de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: IGLESIAS CARRIZO JAVIER;VAZQUEZ VALLE PATRICIA;PEREZ PEREZ RUTH. Nombramientos.Apoderado: VAZQUEZ VALLE PATRICIA;IGLESIAS CARRIZO JAVIER;CASTRO LOPES JOSE DINIS. Datos registrales. T 26096 ,F 54, S 8, H M 159291, I/A 52 (27.07.11).

07 de Septiembre de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 54, S 8, H M 159291, I/A 51 (28.07.10).

01 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBIO GONZALEZ FELIPE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ PEREZ RUTH. Apo.Manc.:VAZQUEZ VALLE PATRICIA;IGLESIAS CARRIZO JAVIER;SANCHEZ ARDAVIN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26096 ,F 53, S 8, H M 159291, I/A 50 (18.01.10).

28 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 26096 , F 53, S 8, H M 159291, I/A 49 (16.10.09).

27 de Julio de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ PEREZ RUTH;IGLESIAS CARRIZO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUBIOGONZALEZ FELIPE;IGLESIAS CARRIZO JAVIER;VAZQUEZ VALLE PATRICIA. Datos registrales. T 26096 , F 52, S 8, H M 159291,I/A 48 (16.07.09).

05 de Junio de 2009
Revocaciones. Apoderado: PEREZ PEREZ RUTH;ROMANO TERRADEZ GREGORIO;IGLESIAS CARRIZO JAVIER.Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ PEREZ RUTH;IGLESIAS CARRIZO JAVIER. Datos registrales. T 26096 , F 51, S 8, H M159291, I/A 47 (26.05.09).

26 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apoderado: PEREZ PEREZ RUTH;ROMANO TERRADEZ GREGORIO;IGLESIAS CARRIZO JAVIER.

04 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: FIGUEIREDO PATRICIO VIEIRA JOSE. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ ARDAVINFRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: SANCHEZ ARDAVIN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 26096 , F 50, S 8, H M159291, I/A 45 (20.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información