Actos BORME de Damin Sl
02 de Enero de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: VENTURA ROLDAN ALBERT. Datos registrales. T 21830 , F 109, S 8, H B 27780, I/A 17(22.12.22).
08 de Abril de 2021Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: VENTURA CISTERNAS CELESTI;ROLDAN NAVARRO ELENA. Nombramientos. ADM.UNICO:VENTURA CISTERNAS CELESTI. Datos registrales. T 21830 , F 109, S 8, H B 27780, I/A 16 (29.03.21).
17 de Julio de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: ROLDAN NAVARRO ELENA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: VENTURA CISTERNASCELESTI;ROLDAN NAVARRO ELENA. Datos registrales. T 21830 , F 108, S 8, H B 27780, I/A 15 (10.07.19).
18 de Enero de 2019Revocaciones. ADMINISTR.: VENTURA CISTERNAS CELESTINO. Nombramientos. ADM.UNICO: ROLDAN NAVARRO ELENA.Datos registrales. T 21830 , F 108, S 8, H B 27780, I/A 14 (10.01.19).
07 de Marzo de 2018Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: NEPAVE 2007 SL. Datos registrales. T 21830 , F 108, S 8, H B 27780, I/A 13(27.02.18).
02 de Diciembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.680,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.201.680,00 Euros. Datos registrales. T 21830 , F 107, S 8, HB 27780, I/A 12 (24.11.16).
05 de Noviembre de 2012Cambio de domicilio social. CL CALABRIA Num.94 P.BA PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 21830 , F 106, S 8, H B27780, I/A 11 (24.10.12).