Actos BORME de Daorje Sl
26 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MORENO MENDEZ RUBEN. Nombramientos. Apo.Sol.: CANOSA CARRO CARLOS RAMON.Apo.Manc.: CANOSA CARRO CARLOS RAMON. Apo.Sol.: PEREZ MELCHOR JAVIER. Apo.Manc.: PEREZ MELCHOR JAVIER.Datos registrales. T 4443 , F 204, S 8, H AS 39380, I/A 64 (19.09.23).
18 de Mayo de 2022Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4443 , F 203, S 8, H AS 39380, I/A62 ( 9.05.22).
29 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: ZORITA PADILLA MIGUEL;MURIEL VELASCO PEDRO LUCIO. Datos registrales. T 4443 , F 202, S 8,H AS 39380, I/A 61 (20.07.21).
08 de Julio de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Apo.Manc.: FERNANDEZNOVAL JAVIER. Apo.Sol.: FERNANDEZ NOVAL JAVIER. Nombramientos. Apoderado: QUILES PUENTE RAMON LUIS;MORENOMENDEZ RUBEN;LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 3868 , F 158, S 8, H AS 39380, I/A 60 (29.06.21).
08 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 158, S 8, H AS 39380, I/A59 (26.02.21).
20 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 158, S 8, H AS 39380, I/A58 (12.03.20).
28 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES VALENCIA MANUEL. Nombramientos. Consejero: ZORITA PADILLA MIGUEL. Datosregistrales. T 3868 , F 158, S 8, H AS 39380, I/A 57 (21.01.20).
26 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: QUILES PUENTE RAMON LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO.Datos registrales. T 3868 , F 157, S 8, H AS 39380, I/A 56 (17.12.19).
26 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 157, S 8, H AS 39380, I/A55 (18.03.19).
25 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: VILLAZON PIDAL JESUS ENRIQUE. Apo.Sol.: VILLAZON PIDAL JESUS ENRIQUE. Nombramientos.Apo.Sol.: FERNANDEZ NOVAL JAVIER. Apo.Manc.: FERNANDEZ NOVAL JAVIER. Datos registrales. T 3868 , F 155, S 8, H AS39380, I/A 54 (14.02.19).
06 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: VILLAZON PIDAL JESUS. Apo.Manc.: VILLAZON PIDAL JESUS ENRIQUE. Apoderado: ALVAREZFERNANDEZ JAVIER. Apo.Manc.: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Apo.Sol.: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Apo.Manc.:RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ;TORRES VALENCIA MANUEL;GRUSCHKA MARTIN.Datos registrales. T 3868 , F 155, S 8, H AS 39380, I/A 53 (30.08.18).
12 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 155, S 8, H AS 39380, I/A52 ( 2.03.18).
06 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.003,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 3868 , F 154, S 8, H AS 39380, I/A 51 (26.01.18).
24 de Enero de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO;MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Apo.Manc.: MURIELVELASCO PEDRO-LUCIO. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Apo.Manc.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Apo.Sol.: VILLAZONPIDAL JESUS ENRIQUE. Apo.Manc.: VILLAZON PIDAL JESUS ENRIQUE. Apo.Sol.: ZORITA PADILLA MIGUEL. Apo.Manc.: ZORITAPADILLA MIGUEL. Apo.Sol.: ALVAREZ FERNANDEZ JAVIER;QUILES PUENTE RAMON LUIS;OVIES FERNANDEZ MARIAMERCEDES;LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 3868 , F 93, S 8, H AS 39380, I/A 50 (15.01.18).
09 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUSCHKA MARTIN. Secretario: TORRES VALENCIA MANUEL. Nombramientos. Consejero:MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. SecreNoConsj: PENDAS AGUIRRE ANGEL. Datos registrales. T 3868 , F 92, S 8, H AS39380, I/A 49 ( 1.06.17).
21 de Marzo de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 92, S 8, H AS 39380, I/A48 (10.03.17).
10 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: JUANES HERNANDEZ JUAN. Datos registrales. T 3868 , F 92, S 8, H AS 39380, I/A 47 ( 2.03.17).
24 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Apo.Manc.: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datosregistrales. T 3868 , F 92, S 8, H AS 39380, I/A 46 (17.06.16).
05 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 49, S 8, H AS 39380, I/A45 (29.03.16).
20 de Marzo de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL;HIDALGO TRUCIOSJOAQUIN. Apo.Sol.: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Apoderado: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Apo.Manc.: HIDALGO TRUCIOSJOAQUIN. Apo.Sol.: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Apo.Manc.: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Datos registrales. T 3868 , F 49, S8, H AS 39380, I/A 44 (11.03.15).
09 de Marzo de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 49, S 8, H AS 39380, I/A43 (27.02.15).
12 de Diciembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.001,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3868 , F 46, S 8, H AS 39380, I/A 39 ( 3.12.14).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NIETO MARTINEZ JOSE MIGUEL. Consejero: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL;HIDALGOTRUCIOS JOAQUIN;VILLAZON PIDAL JESUS. Presidente: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero:GRUSCHKA MARTIN;TORRES VALENCIA MANUEL;ZORITA LEES MIGUEL. Secretario: TORRES VALENCIA MANUEL. Presidente:ZORITA LEES MIGUEL. Cons.Del.Sol: ZORITA LEES MIGUEL. Apo.Sol.: GRUSCHKA MARTIN;TORRES VALENCIA MANUEL.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Otros conceptos: Modificaci贸n de los estatutos sociales por
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ENGINEERING SOLUTIONS SARL. Datos registrales. T 3868 , F49, S 8, H AS 39380, I/A 41 ( 3.12.14).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.002,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de losestatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3868 , F 49, S 8, H AS 39380, I/A 42 ( 3.12.14).
29 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: RIVERA PEREZ ANGEL. Apo.Sol.: RIVERA PEREZ ANGEL. Nombramientos. Apo.Manc.: MURIELVELASCO PEDRO-LUCIO. Apo.Sol.: MURIEL VELASCO PEDRO-LUCIO. Datos registrales. T 3868 , F 45, S 8, H AS 39380, I/A 38(22.07.14).
30 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PLA VILA AGUSTIN. Datos registrales. T 3868 , F 45, S 8, H AS 39380, I/A 37 (22.05.14).
10 de Enero de 2014Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DANIGAL MEDIOAMBIENTE SA. Datos registrales. T 3868 , F 45, S 8, H AS39380, I/A 36 (30.12.13).
19 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 45, S 8, H AS 39380, I/A35 (11.12.13).
22 de Octubre de 2013Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: RECUPERACIONES Y TRATAMIENTOS FERRICOS SA. INGENIERIA YPROYECTOS MEDIOAMBIENTALES SA. Datos registrales. T 3868 , F 44, S 8, H AS 39380, I/A 33 ( 1.10.13).
01 de Julio de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.000.006,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3868 , F 44, S 8, H AS 39380, I/A 32 (21.06.13).
31 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 43, S 8, H AS 39380, I/A31 (23.01.13).
20 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Apo.Manc.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Nombramientos.Apo.Sol.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Apo.Manc.: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3868 , F 42, S 8,H AS 39380, I/A 30 ( 6.11.12).
31 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Presidente: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Nombramientos.Presidente: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3868 , F 42, S 8, H AS 39380, I/A 29 (19.10.12).
20 de Septiembre de 2012Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ALFAREROS S/N - PARQUEEMPRESARIAL PRINCIPADO D (AVILES). Datos registrales. T 3868 , F 41, S 8, H AS 39380, I/A 28 (10.09.12).
28 de Mayo de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: QUEMADA SAENZ-BADILLO JORGE. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS;GARCIAMANZANEDA JOSE URBANO. Datos registrales. T 3868 , F 40, S 8, H AS 39380, I/A 26 (16.05.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: VILLAZON PIDAL JESUS ENRIQUE. Apo.Manc.: VILLAZON PIDAL JESUS ENRIQUE. Datosregistrales. T 3868 , F 40, S 8, H AS 39380, I/A 27 (17.05.12).
04 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Apo.Manc.: RUBIO GARCIA MARIA CRUZ. Datos registrales. T 3868 ,F 38, S 8, H AS 39380, I/A 25 (22.03.12).
21 de Marzo de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 38, S 8, H AS 39380, I/A24 ( 7.03.12).
02 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: DESTI TERRANOVA S.L. Nombramientos. Consejero: PLA VILA AGUSTIN. Datos registrales. T3868 , F 38, S 8, H AS 39380, I/A 23 (21.02.12).
01 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 3868 , F 38, S 8, H AS 39380, I/A 22 (20.01.12).
02 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: GIL RODRIGUEZ RAMON. Revocaciones. Apo.Manc.: GIL RODRIGUEZ RAMON. Apo.Sol.: GILRODRIGUEZ RAMON. Nombramientos. Consejero: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Presidente: VILLAZAN GIL BERNARDOJOSE. Apo.Sol.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Apo.Manc.: VILLAZAN GIL BERNARDO JOSE. Datos registrales. T 3868 , F 36,S 8, H AS 39380, I/A 21 (19.07.11).
24 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA CASADO JOSE MARIA. Datos registrales. T 3868 , F 36, S 8, H AS 39380, I/A 20(12.05.11).
11 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos:15. Cierre del Ejercicio.-. Datos registrales. T 3868 , F 36, S 8, H AS 39380, I/A 19 ( 1.02.11).
03 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3868 , F 36, S 8, H AS 39380, I/A18 (24.01.11).
21 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 3776 , F 71, S 8, H AS 39380, I/A 17(11.01.11).
28 de Diciembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.003.006,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datos registrales. T 3776 , F 71, S 8, H AS 39380, I/A 16 (17.12.10).
14 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ HERNANDEZ ABELARDO. Nombramientos. Consejero: DESTI TERRANOVA S.L. Datosregistrales. T 3776 , F 70, S 8, H AS 39380, I/A 15 (30.09.10).
05 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN;IGLESIAS BARCIA LEANDRO. Datos registrales. T 3776 , F 69, S 8,H AS 39380, I/A 14 (23.03.10).
02 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO VILLARON ORLANDO. Nombramientos. Consejero: VILLAZON PIDAL JESUS. Datosregistrales. T 3776 , F 67, S 8, H AS 39380, I/A 12 (20.01.10).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALONSO VILLARON ORLANDO. Apo.Sol.: ALONSO VILLARON ORLANDO. Nombramientos.Apo.Sol.: VILLAZON PIDAL JESUS. Datos registrales. T 3776 , F 67, S 8, H AS 39380, I/A 13 (20.01.10).
01 de Diciembre de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL;ALONSO VILLARON JESUS. Apo.Sol.: MURIEL JIMENEZ JOSEMANUEL;ALONSO VILLARON JESUS. Nombramientos. Apo.Sol.: GIL RODRIGUEZ RAMON;HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN.Apo.Manc.: GIL RODRIGUEZ RAMON;HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Apo.Sol.: RIVERA PEREZ ANGEL. Apo.Manc.: RIVERAPEREZ ANGEL. Datos registrales. T 3776 , F 64, S 8, H AS 39380, I/A 11 (17.11.09).
21 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO VILLARON JESUS. Datos registrales. T 3776 , F 64, S 8, H AS 39380, I/A 8 ( 9.10.09).
Nombramientos. Apoderado: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Datos registrales. T 3776 , F 64, S 8, H AS 39380, I/A 9 ( 9.10.09).
Ceses/Dimisiones. Presidente: MURIEL JIMENEZ JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: GIL RODRIGUEZ RAMON.Presidente: GIL RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 3776 , F 64, S 8, H AS 39380, I/A 10 ( 9.10.09).
04 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: ALVAREZ GUTIERREZ JOSE ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: NIETO MARTINEZ JOSEMIGUEL. Datos registrales. T 3776 , F 63, S 8, H AS 39380, I/A 6 (25.08.09).
Nombramientos. Consejero: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Datos registrales. T 3776 , F 63, S 8, H AS 39380, I/A 7 (25.08.09).
13 de Marzo de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Apo.Sol.: HIDALGO TRUCIOS JOAQUIN. Datos registrales. T 3776 ,F 62, S 8, H AS 39380, I/A 5 ( 3.03.09).
06 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3776 , F 59, S 8, H AS 39380, I/A 3(26.01.09).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MANZANEDA JOSE URBANO. Datos registrales. T 3776 , F 61, S 8, H AS 39380, I/A 4(26.01.09).
22 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: QUEMADA SAENZ-BADILLO JORGE. Nombramientos. Consejero: LOPEZ HERNANDEZABELARDO. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. PQUEEMPRESARIAL PRINCIPADO DE ASTURIAS - PARCELA (AVILES). Datos registrales. T 3776 , F 59, S 8, H AS 39380, I/A 2(12.01.09).