Actos BORME de Darty Hispana Sa
08 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RAGOEN VICTOR JOHAN A;ENOCH SIMON JOCELYN;PLATT DOMINIC JAMES. Presidente:PLATT DOMINIC JAMES. Secretario: ENOCH SIMON JOCELYN. Nombramientos. Liquidador: KESA SPAIN LIMITED.Representan: ALVAREZ DEL CASTILLO NURIA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 27321 , F 177, S 8, H M331948, I/A 53 (29.04.14).
11 de Diciembre de 2013Cambio de domicilio social. AVDA LEONARDO DA VINCI 8 - OFICINA 228, PI: LA CAR (GETAFE). Datos registrales. T 27321 , F177, S 8, H M 331948, I/A 52 ( 2.12.13).
26 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: FABRE-DARCOURT JEAN YVES. Nombramientos. Apoderado: JAUBERT BENOIT;THONON FRIASMARIA ANGELES;CEGARRA BULNES JUAN PABLO;ALVAREZ DEL CASTILLO NURIA;RAGOEN VICTOR JOHAN A;ENOCHSIMON JOCELYN;PLATT DOMINIC JAMES. Datos registrales. T 27321 , F 174, S 8, H M 331948, I/A 51 (18.07.13).
01 de Abril de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY. Apo.Manc.: FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY. Apoderado:FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY;FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY;FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY;FALQUE-PIERROTIN'STHIERRY;FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY;FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY. Datos registrales. T 27321 , F 174, S 8, H M331948, I/A 50 (21.03.13).
07 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ENOCH SIMON-JOCELYN. Secretario: ENOCH SIMON-JOCELYN. Consejero: RAGOEN'SVIC;FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY. Presidente: FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY. Consejero: PLATT DOMINIC JAMES.Nombramientos. Consejero: RAGOEN VICTOR JOHAN A;ENOCH SIMON JOCELYN;PLATT DOMINIC JAMES. Presidente: PLATTDOMINIC JAMES. Secretario: ENOCH SIMON JOCELYN. Datos registrales. T 27321 , F 173, S 8, H M 331948, I/A 49 (28.02.13).
02 de Enero de 2013Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: KESA SPAIN LIMITED. Datos registrales. T 27321 , F 173, S 8, HM 331948, I/A 48 (24.12.12).
07 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27321 , F 172, S 8, H M 331948,I/A 47 (28.11.12).
31 de Julio de 2012Revocaciones. Apoderado: HUE STEPHANE MARC CLAUDE;HUE STEPHANE MARC CLAUDE;HUE STEPHANE MARC CLAUDE.Datos registrales. T 27321 , F 172, S 8, H M 331948, I/A 46 (19.07.12).
25 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: JAUBERT BENOIT;FABRE-DARCOURT JEAN YVES;CEGARRA BULNES JUAN PABLO;FALQUE-PIERROTIN'S THIERRY;RAGOEN VICTOR JOHAN A;ENOCH SIMON JOCELYN;PLATT DOMINIC JAMES;FALQUE-PIERROTIN'STHIERRY;RAGOEN VICTOR JOHAN A;PLATT DOMINIC JAMES;ENOCH SIMON JOCELYN;JAUBERT BENOIT;FABRE DARCOURTJEAN YVES GEORGES RAYMOND;CEGARRA BULNES JUAN PABLO. Datos registrales. T 27321 , F 169, S 8, H M 331948, I/A 45(14.06.12).