Actos BORME de Dasy Logistica Y Transporte Sl
13 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PROTEINAS Y GRASAS GIMENO SL. Nombramientos. LiqUnico: GIMENO BORRAS JOSEMARIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Liquidador Unico. Disoluci贸n.Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 5268 , F 152, S 8, H SE 85371, I/A 16 ( 3.03.15).
16 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: GIMENO BRIAS DANIEL. Datos registrales. T 5268 , F 151, S 8, H SE 85371, I/A 15 ( 7.01.15).
15 de Septiembre de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: SALGADO MORA MARCELINO;MORALES TRESCENTS XAVIER. Datos registrales. T 5268 , F 150, S8, H SE 85371, I/A 12 ( 3.09.14).
Nombramientos. Apoderado: BRIAS GONZALEZ MARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T 5268 , F 150, S 8, H SE 85371, I/A13 ( 3.09.14).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Datos registrales.T 5268 , F 151, S 8, H SE 85371, I/A 14 ( 3.09.14).
09 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 5268 , F 149, S 8, H SE 85371, I/A 11 (30.09.13).
22 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: DUCH SOLE MONTSERRAT. Datos registrales. T 5194 , F 133, S 8, H SE 85371, I/A 8 ( 7.11.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: SALGADO MORA MARCELINO;MORALES TRESCENTS XAVIER. Datos registrales. T 5194 , F 133,S 8, H SE 85371, I/A 9 ( 7.11.12).
Nombramientos. Apoderado: CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5194 , F 134, S 8, H SE 85371, I/A 10 (7.11.12).
11 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL. Datos registrales. T 5194 , F 130, S 8, H SE 85371, I/A 5 (1.03.11).
Nombramientos. Apoderado: CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5194 , F 131, S 8, H SE 85371, I/A 6 (1.03.11).
Nombramientos. Apoderado: DUCH SOLE MONTSERRAT. Datos registrales. T 5194 , F 132, S 8, H SE 85371, I/A 7 ( 1.03.11).
10 de Febrero de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL;CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5194 , F130, S 8, H SE 85371, I/A 4 (31.01.11).
29 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apoderado: BRIAS GONZALEZ MARIA MONTSERRAT. Datos registrales. T 5194 , F 130, S 8, H SE 85371, I/A 3(16.11.10).
12 de Marzo de 2010Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA ECIJA - ALMARGEN Km27 - APARTADO DE CORREOS, (OSUNA). Datos registrales. T 5194 , F 129, S 8, H SE 85371, I/A 2 (25.02.10).
22 de Mayo de 2009Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PROAUDIT SL. Datos registrales. T 34480 , F 92, S 8, H B 248102, I/A 12 ( 8.05.09).
13 de Abril de 2009Nombramientos. APODERADO: RODRIGUEZ MONTERDE RAFAEL;CARRILLO BERMUDEZ ANTONIO. Datos registrales. T34480 , F 92, S 8, H B 248102, I/A 11 (30.03.09).