Actos BORME de David Riquelme Sa
20 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: PASTO ROMA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4095 , F 219, S 8, H A 9979, I/A 58(11.10.23).
04 de Octubre de 2022Revocaciones. Auditor: G.M.P. AUDITORES SAP. Datos registrales. T 4095 , F 219, S 8, H A 9979, I/A 57 (26.09.22).
01 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MA脩OGIL ANGELA TERESA. Datos registrales. T 4095 , F 218, S 8, H A 9979, I/A 56(24.01.22).
25 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: G.M.P. AUDITORES SAP. Datos registrales. T 4095 , F 218, S 8, H A 9979, I/A 55 (17.11.21).
24 de Febrero de 2021Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO;GALVEZ TORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4095 , F218, S 8, H A 9979, I/A 54 (16.02.21).
09 de Febrero de 2021Reelecciones. Adm. Solid.: VIDAL ESTEVE MARTA;MARTIN LOPEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 4095 , F 218, S 8,H A 9979, I/A 53 ( 1.02.21).
21 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: GALVEZ TORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4095 , F 218, S 8, H A 9979, I/A 52(14.02.20).
20 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DIAZ ENCARNACION. Datos registrales. T 4095 , F 217, S 8, H A 9979, I/A 51 (12.02.20).
25 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO. Datos registrales. T 4095 , F 216, S 8, H A 9979, I/A 50(18.01.19).
27 de Noviembre de 2018Nombramientos. Auditor: G.M.P. AUDITORES SAP. Datos registrales. T 4095 , F 216, S 8, H A 9979, I/A 49 (16.11.18).
16 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: PASTO ROMA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 4095 , F 216, S 8, H A 9979, I/A 48 ( 7.11.18).
14 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: VIDAL SOLER ANTONIO. Datos registrales. T 4095 , F 216, S 8, H A 9979, I/A 47 ( 5.11.18).
24 de Abril de 2018Nombramientos. Adm. Solid.: VIDAL ESTEVE MARTA. Datos registrales. T 4095 , F 216, S 8, H A 9979, I/A 46 (16.04.18).
05 de Febrero de 2018Otros conceptos: ADAPTADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE JULIO DETEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MAPU SL.Datos registrales. T 3249 , F 69, S 8, H A 9979, I/A 45 (29.01.18).
20 de Diciembre de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SERVIMATIC SL. Datos registrales. T 3249 , F 69, S 8, H A 9979, I/A 44 (12.12.17).
29 de Mayo de 2017Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MA脩OGIL ANGELA TERESA. Datos registrales. T 3249 , F 69, S 8, H A 9979, I/A 43(19.05.17).
23 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: VIDAL ESTEVE MARTA. Datos registrales. T 3249 , F 68, S 8, H A 9979, I/A 42 (16.06.16).
23 de Mayo de 2016Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MARTIN LOPEZ MARIA DEL CARMEN;VIDAL SOLER ANTONIO. Consejero: VIDAL SOLERANTONIO. Secretario: VIDAL SOLER ANTONIO. Consejero: RIQUELME GONZALEZ DAVID;MARTIN LOPEZ MARIA DEL CARMEN.Presidente: MARTIN LOPEZ MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Adm. Solid.: VIDAL SOLER ANTONIO;MARTIN LOPEZMARIA DEL CARMEN. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 16 . Organos de la sociedad.- . ARTICULO 24 . Convocatoriajunta.- . ARTICULO 28 . Organo de administraci贸n de la sociedad.. ARTICULO 29 . Representaci贸n de la sociedad.-. ARTICULO 30潞.Duraci贸n 贸rgano de administraci贸n.-. ARTICULO 31 . Retribuci贸n 贸rgano de administraci贸n.-. ARTICULO 33潞. Obligaciones 贸rgano deadministraci贸n. ARTICULO 36 . Disoluci贸n y liquidaci贸n. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 3249 , F 68, S 8, H A 9979, I/A 41 (13.05.16).
04 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DIAZ ENCARNACION. Datos registrales. T 3249 , F 68, S 8, H A 9979, I/A 40 (23.04.15).
30 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: GALVEZ TORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3211 , F 135, S 8, H A 9979, I/A 39(22.04.15).
31 de Diciembre de 2014Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: RECREATIVOS GOLIAT SL. Datos registrales. T 3211 , F 135, S 8, H A 9979, I/A38 (22.12.14).
10 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO. Datos registrales. T 3211 , F 134, S 8, H A 9979, I/A 37(28.02.14).
04 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apoderado: PASTO ROMA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3211 , F 134, S 8, H A 9979, I/A 36(26.11.13).
29 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: GIMENEZ MA脩OGIL ANGELA TERESA. Nombramientos. Apoderado: GIMENEZ MA脩OGIL ANGELATERESA. Datos registrales. T 3211 , F 125, S 8, H A 9979, I/A 35 (18.05.12).
28 de Mayo de 2012Nombramientos. Cons.Del.Sol: MARTIN LOPEZ MARIA DE CARMEN. Datos registrales. T 3211 , F 125, S 8, H A 9979, I/A 34(17.05.12).
25 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VIDAL SOLER ANTONIO;MARTIN LOPEZ MARIA DE CARMEN. Nombramientos. Cons.Del.Sol:VIDAL SOLER ANTONIO. Reelecciones. Consejero: VIDAL SOLER ANTONIO. Secretario: VIDAL SOLER ANTONIO. Consejero:RIQUELME GONZALEZ DAVID;MARTIN LOPEZ MARIA DE CARMEN. Presidente: MARTIN LOPEZ MARIA DE CARMEN. Datosregistrales. T 3211 , F 125, S 8, H A 9979, I/A 33 (15.05.12).
24 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: GALVEZ TORRES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 3211 , F 125, S 8, H A 9979, I/A 32(14.06.10).
23 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: NAVARRO DIAZ ENCARNACION. Datos registrales. T 3211 , F 124, S 8, H A 9979, I/A 31 (11.06.10).
21 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: GALVEZ TORRES JUAN CARLOS;NAVARRO DIAZ ENCARNACION. Datos registrales. T 3211 , F124, S 8, H A 9979, I/A 30 (10.06.10).
12 de Febrero de 2010Nombramientos. Presidente: MARTIN LOPEZ MARIA CARMEN. Datos registrales. T 3211 , F 124, S 8, H A 9979, I/A 29 ( 1.02.10).
11 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: FIQUEREDO ARANDA JOSE LUIS. Presidente: FIQUEREDO ARANDA JOSE LUIS. Datosregistrales. T 3211 , F 124, S 8, H A 9979, I/A 28 ( 1.02.10).
12 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGILIO. Datos registrales. T 3211 , F 123, S 8, H A 9979, I/A 27 (3.03.09).
11 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: RIQUELME GONZALEZ DAVID. Presidente: RIQUELME GONZALEZ DAVID. Nombramientos.Presidente: FIGUEREDO ARANDA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3211 , F 123, S 8, H A 9979, I/A 26 (30.01.09).
22 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: PASTO ROMA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 3211 , F 123, S 8, H A 9979, I/A 25(12.01.09).