Buscador CIF Logo

Actos BORME De Dietrich Thermique Iberia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera De Dietrich Thermique Iberia Sl

Actos BORME De Dietrich Thermique Iberia Sl - B63808687

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para De Dietrich Thermique Iberia Sl con CIF B63808687

馃敊 Perfil de De Dietrich Thermique Iberia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de De Dietrich Thermique Iberia Sl

28 de Julio de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLANCH VALLHONRAT JUAN;BLANCH VALLHONRAT JUAN;SANCHEZ TORRESESTHER;SERRA VENTURA ENRIC;SOLE GARCIA RUTH;ANDREU PHILPOTT XAVIER. Apo.Sol.: DE LA TORRE ASPE ANAMARIA. Apo.Man.Soli: REAL DIEZ JOSE LUIS;VILANOVA GIRALT LLUIS;VILANOVA GIRALT LLUIS;ALCOVER ARNAUJAIME;HELLIN PINEDA LUIS;HERNANDEZ TOSCA DAVID. Apo.Sol.: BORI KAUFFMANN CESAR;TORNAMORELL GARCIAREGINA;TRAPIELLA MARTINEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 36627 , F 177, S 8, H M 657097, I/A 14 (21.07.23).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MESTRES SOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Nombramientos. Adm. Unico:BLANCH VALLHONRAT JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 36627 , F 182, S 8, H M 657097, I/A 15 (21.07.23).

22 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36627 , F 177, S 8, H M 657097,I/A 13 (15.12.22).

04 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;MATA LABAJOS JOSE ANTONIO;RUIZ PELLEJERO MIGUELANGEL;RUIZ PELLEJERO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ TORRES ESTHER;MESTRES SOLAJORGE;MESTRES SOLA JORGE. Datos registrales. T 36627 , F 176, S 8, H M 657097, I/A 12 (27.10.22).

09 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES ESTHER. Datos registrales. T 36627 , F 175, S 8, H M 657097, I/A 11 ( 4.09.22).

01 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36627 , F 175, S 8, H M 657097,I/A 10 (24.11.21).

08 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO. Consejero: BLANCH VALLHONRAT JUAN;VAN OOIJEN JANROELF. Presidente: VAN OOIJEN JAN ROELF. Consejero: MESTRES SOLA JORGE. Nombramientos. Adm. Mancom.: MESTRESSOLA JORGE;BLANCH VALLHONRAT JUAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administradores mancomunados. Datos registrales. T 36627 , F 174, S 8, H M 657097, I/A 8 ( 1.06.21).

Revocaciones. Apoderado: VAN OOIJEN JAN ROELF. Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ SOLE SERGIO;ARTIGAS GRAUELENA. Datos registrales. T 36627 , F 175, S 8, H M 657097, I/A 9 ( 1.06.21).

18 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36627 , F 174, S 8, H M 657097,I/A 7 (11.11.20).

16 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36627 , F 174, S 8, H M 657097,I/A 6 ( 8.12.19).

24 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: BASILE SALVATORE. Datos registrales. T 36627 , F 174, S 8, H M 657097, I/A 5 (17.06.19).

05 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SUBIRANA ORTIN FRANCESC. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ SOLE SERGIO.Datos registrales. T 36627 , F 173, S 8, H M 657097, I/A 3 (28.08.18).

Revocaciones. Apoderado: SUBIRANA ORTIN FRANCESC;SUBIRANA ORTIN FRANCESC;SUBIRANA ORTIN FRANCESC. Datosregistrales. T 36627 , F 173, S 8, H M 657097, I/A 4 (28.08.18).

04 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ LOPEZ DE HOYOS 35 BAJOS (MADRID). Datos registrales. T 36627 , F 173, S 8, H M 657097, I/A2 (27.11.17).

06 de Septiembre de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 43053 , F 56, S 8, H B299075, I/A 27 (29.08.17).

03 de Febrero de 2015
Revocaciones. APODERADO: PI JULIA LUIS;PI JULIA LUIS;ADRIAN EGERTON DARLING;RUBIO QUINTANA SANTIAGO;PIJULIA LLUIS. Nombramientos. APODERAD.SOL: RUIZ PELLEJERO MIGUEL ANGEL. APOD.MANCOMU: JAN ROELF VANOOIJEN. Datos registrales. T 43053 , F 55, S 8, H B 299075, I/A 26 (27.01.15).

11 de Noviembre de 2014
Cambio de domicilio social. CL SALVADOR ESPRIU Num.11 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datos registrales. T 43053 , F55, S 8, H B 299075, I/A 25 (30.10.14).

19 de Mayo de 2014
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: BLANCH VALLHONRAT JUAN. Datos registrales. T 43053 , F 54, S 8, H B 299075, I/A 24 (8.05.14).

06 de Marzo de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: JOHN TIERNEY. Nombramientos. CONSEJERO: BLANCH VALLHONRAT JUAN. Datosregistrales. T 43053 , F 54, S 8, H B 299075, I/A 23 (27.02.13).

27 de Julio de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: ADRIAN EGERTON DARLING. PRESIDENTE: ADRIAN EGERTON DARLING. Nombramientos.CONSEJERO: MESTRES SOLA JORGE. PRESIDENTE: JAN ROELF VAN OOIJEN. Datos registrales. T 43053 , F 54, S 8, H B299075, I/A 22 (16.07.12).

21 de Mayo de 2012
Otros conceptos: CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO,PASANDO A DENOMINARSE:BDRTHERMEA IBERIA SL. Datos registrales. T 43053 , F 53, S 8, H B 299075, I/A 21 ( 9.05.12).

08 de Mayo de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 60,00 Euros. Resultante Suscrito: 53.520,00 Euros. Datos registrales. T 43053 , F 52, S 8, H B299075, I/A 20 (25.04.12).

14 de Marzo de 2012
Nombramientos. APODERADO: MESTRES SOLA JORGE. Datos registrales. T 37736 , F 79, S 8, H B 299075, I/A 19 ( 2.03.12).

10 de Febrero de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: MARTYN COFFEY. Nombramientos. CONSEJERO: JAN ROELF VAN OOIJEN. Datos registrales.T 37736 , F 79, S 8, H B 299075, I/A 18 (31.01.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n