Buscador CIF Logo

Actos BORME Dec Comunicacion Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Dec Comunicacion Sa

Actos BORME Dec Comunicacion Sa - A08753550

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Dec Comunicacion Sa con CIF A08753550

🔙 Perfil de Dec Comunicacion Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Dec Comunicacion Sa

20 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: BYRNES JOHN J. Nombramientos. Consejero: SANDERS MARTIN PAUL. Datos registrales. T36935 , F 120, S 8, H M 660566, I/A 14 (13.01.23).

01 de Junio de 2022
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 36935 , F 120, S 8, H M 660566, I/A 13 (25.05.22).

24 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: PEREZ SALMERON FRANCISCO;ARBOLI TRIAS MARTA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;MEDINAEXPOSITO PABLO JESUS. Nombramientos. Apo.Manc.: ARBOLI TRIAS MARTA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;BARRAGANFERNANDEZ LUIS JAVIER. Datos registrales. T 36935 , F 119, S 8, H M 660566, I/A 12 (17.05.21).

14 de Mayo de 2021
Nombramientos. Auditor: VARELA PIRES ANGEL 004060155Y SLNE. Datos registrales. T 36935 , F 119, S 8, H M 660566, I/A 11( 7.05.21).

17 de Marzo de 2021
Nombramientos. Auditor: AUDITORES DE FUNDACIONES ASOCIACIONES Y ENTIDADES. Datos registrales. T 36935 , F 119, S8, H M 660566, I/A 10 (10.03.21).

30 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ SALMERON FRANCISCO. Presidente: PEREZ SALMERON FRANCISCO. Revocaciones.Apoderado: LOPEZ GIMENEZ TERESA. Nombramientos. Consejero: MOSER JAMES THOMAS. Presidente: MOSER JAMESTHOMAS. Datos registrales. T 36935 , F 117, S 8, H M 660566, I/A 7 (23.10.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;LOPEZ GIMENEZ TERESA;CIRUJEDA DOMINGUEZ LORENA.Datos registrales. T 36935 , F 118, S 8, H M 660566, I/A 8 (23.10.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 36935 , F 118, S 8, H M 660566, I/A 9(23.10.20).

04 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;PEREZ SALMERONFRANCISCO;ARBOLI TRIAS MARTA. Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ SALMERON FRANCISCO;ARBOLI TRIASMARTA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Datos registrales. T 36935 , F 116, S 8, H M660566, I/A 6 (27.05.20).

09 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Representan: WALSHE WILLIAM ST JOHN. Consejero: BBDO ESPAÑA SA;CAVANAGH HELENROSINA;BYRNES JOHN J;PEREZ SALMERON FRANCISCO. Presidente: PEREZ SALMERON FRANCISCO. Nombramientos.Consejero: CAVANAGH HELEN ROSINA;BYRNES JOHN J;PEREZ SALMERON FRANCISCO. Presidente: PEREZ SALMERONFRANCISCO. Datos registrales. T 36935 , F 116, S 8, H M 660566, I/A 5 ( 2.10.18).

20 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ PEREZ CONCEPCION. Apo.Manc.: SEGURA RODA FEDERICO;FERRER LORENZOIGNACI. Datos registrales. T 36935 , F 116, S 8, H M 660566, I/A 4 (13.04.18).

08 de Enero de 2018
Cambio de domicilio social. C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 4 (MADRID). Datos registrales. T 36935 , F 112, S 8, H M660566, I/A 2 (29.12.17).

21 de Noviembre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;LOPEZ GIMENEZ TERESA. Datos registrales. T 44167 ,F 124, S 8, H B 71763, I/A 54 ( 7.11.17).

18 de Mayo de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 44167 , F 123, S 8, H B 71763, I/A 52 (10.05.17).

Revocaciones. APOD.MANCOMU: PEREZ SALMERON FRANCISCO;YHERLA CAMPAÑA JORDI;GUTIERREZ SANZ JORGEROMAN;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Nombramientos. APOD.MANCOMU: PEREZ SALMERON FRANCISCO;ARBOLITRIAS MARTA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Datos registrales. T 44167 , F 124, S 8, HB 71763, I/A 53 (10.05.17).

21 de Marzo de 2016
Revocaciones. CONSEJERO: JOHN MARK WALKER. Nombramientos. CONSEJERO: HELEN ROSINA CAVANAGH. Datosregistrales. T 44167 , F 123, S 8, H B 71763, I/A 50 (11.03.16).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 44167 , F 123, S 8, H B 71763, I/A 51 (11.03.16).

12 de Enero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 44167 , F 122, S 8, H B 71763, I/A 49 (31.12.14).

10 de Junio de 2014
Revocaciones. APOD.MANCOMU: YHERLA CAMPAÑA JORDI. APODERADO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;MARTINEZPEREZ CONCHA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Nombramientos. APOD.MANCOMU:PEREZ SALMERON FRANCISCO;YHERLA CAMPAÑA JORDI;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;MEDINA EXPOSITO PABLOJESUS. Datos registrales. T 44167 , F 122, S 8, H B 71763, I/A 48 (30.05.14).

02 de Abril de 2014
Nombramientos. APOD.MANCOMU: YHERLA CAMPAÑA JORDI. Datos registrales. T 44167 , F 121, S 8, H B 71763, I/A 47(25.03.14).

06 de Febrero de 2014
Revocaciones. REPR.143 RRM: PETER KEENAN SHERMAN. Nombramientos. REPR.143 RRM: WILLIAM ST JOHN WALSHE.Datos registrales. T 44167 , F 121, S 8, H B 71763, I/A 45 (28.01.14).

Revocaciones. APODERADO: PETER KEENAN SHERMAN. Nombramientos. APODERAD.SOL: ALESSIA FRANCESCUTTI.Datos registrales. T 44167 , F 121, S 8, H B 71763, I/A 46 (28.01.14).

26 de Marzo de 2013
Revocaciones. APODERADO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;GUTIERREZ SANZ JORGEROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER. Nombramientos. APODERADO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;MARTINEZPEREZ CONCHA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Datos registrales. T 34273 , F 70, S 8,H B 71763, I/A 44 (15.03.13).

17 de Diciembre de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;BBDO ESPAÑA SA;JOHN J BYRNES;JOHN MARK WALKER.Nombramientos. CONSEJERO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;BBDO ESPAÑA SA;JOHN J BYRNES;JOHN MARK WALKER.PRESIDENTE: PEREZ SALMERON FRANCISCO. Datos registrales. T 34273 , F 69, S 8, H B 71763, I/A 43 ( 7.12.12).

09 de Octubre de 2012
Revocaciones. APODERADO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZCONCHA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER. Nombramientos. APODERADO: PEREZSALMERON FRANCISCO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUISJAVIER. Datos registrales. T 34273 , F 68, S 8, H B 71763, I/A 42 (28.09.12).

13 de Septiembre de 2012
Revocaciones. SECR.NO CONS: FERRER LORENZO IGNACIO. Nombramientos. SECR.NO CONS: GUTIERREZ SANZ JORGEROMAN. Datos registrales. T 34273 , F 68, S 8, H B 71763, I/A 41 ( 3.09.12).

05 de Octubre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 34273 , F 68, S 8, H B 71763, I/A 40 (26.09.11).

27 de Julio de 2011
Nombramientos. APODERADO: PETER KEENAN SHERMAN. Datos registrales. T 34273 , F 68, S 8, H B 71763, I/A 39 (14.07.11).

16 de Junio de 2011
Revocaciones. APODERADO: PEREZ SALMERON FRANCISCO;BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL;FERRER LORENZOIGNASI;MARTINEZ PEREZ CONCHA;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER. Nombramientos. APODERADO: PEREZSALMERON FRANCISCO;FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;GUTIERREZ SANZ JORGEROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER. Datos registrales. T 34273 , F 66, S 8, H B 71763, I/A 38 ( 7.06.11).

Revocaciones. REPR.143 RRM: BAÑUELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. REPR.143 RRM: PETER KEENANSHERMAN. Datos registrales. T 34273 , F 66, S 8, H B 71763, I/A 37 ( 7.06.11).

26 de Octubre de 2010
Modificaciones estatutarias. ARTS.5 Y 6.- MODIFICACION CLASE ACCIONES SOCIALES. Datos registrales. T 34273 , F 66, S 8,H B 71763, I/A 36 (14.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información