Actos BORME de Decepal Sa
27 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Secretario: GIL MENDEZ BEATRIZ. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 55陋 la publicaci贸n delcese del secretario GIL MENDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 36273 , F 182, S 8, H M 98514, I/A 55 (14.12.21).
21 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GRANDES GARCI MARIA JESUS;MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA. Presidente: MARTINEZFERRANDO LUIS MARIA. Consejero: SILVELA SILVELA MARIA SONSOLES;GUITART GONZALEZ-VALERIO CARMEN.Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 36273 , F 182, S 8, H M 98514, I/A 55 (14.12.21).
P谩gina web de la sociedad. Modificaci贸n de la p谩gina web corporativa.Nueva p谩gina web: www.albasanz14.es. Datos registrales.T 36273 , F 183, S 8, H M 98514, I/A 56 (14.12.21).
22 de Octubre de 2021Revocaciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 36273 , F 182, S 8, H M 98514, I/A 54(15.10.21).
30 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: DURAN DOUSSINAGUE BEATRIZ;ROMERO CUENCA VICENTE. Apo.Man.Soli: PAMPILLON OLMEDOJUAN ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA;ROMERO CUENCA VICENTE. Datosregistrales. T 36273 , F 182, S 8, H M 98514, I/A 53 (23.09.21).
11 de Diciembre de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 402.961,50 Euros. Resultante Suscrito: 446.792,40 Euros. Datos registrales. T 36273 , F181, S 8, H M 98514, I/A 52 ( 2.12.20).
13 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 36273 , F 181, S 8, H M 98514, I/A 51 (5.11.20).
04 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ MEJIA MARIA DOLORES;SERRABOU ARAN ESTER. Nombramientos. Apo.Man.Soli:PAMPILLON OLMEDO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 36273 , F 180, S 8, H M 98514, I/A 50 (27.06.18).
23 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: BENGURIA CALERA PABLO. Vicepresid.: BENGURIA CALERA PABLO. Consejero: COLOMINAPEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 36273 , F 180, S 8, H M 98514, I/A 49 (13.04.18).
09 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 36273 , F 180, S 8, H M 98514, I/A 48 (
02 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ OLIVAR CRISTINA. Nombramientos. Consejero: GUITART GONZALEZ-VALERIOCARMEN;COLOMINA PEREZ DEL RIO FRANCISCO JAVIER. Reelecciones. Consejero: GRANDES GARCI MARIAJESUS;MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA;BENGURIA CALERA PABLO. Presidente: MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA.Vicepresid.: BENGURIA CALERA PABLO. Consejero: SILVELA SILVELA MARIA SONSOLES. Secretario: GIL MENDEZ BEATRIZ.Datos registrales. T 29264 , F 201, S 8, H M 98514, I/A 47 (21.09.17).
31 de Mayo de 2016Revocaciones. Apoderado: JARILLO MOSSI ROSA;JARILLO MOSSI ROSA. Apo.Manc.: JARILLO MOSSI ROSA;ROMEROCUENCA VICENTE. Apoderado: JARILLO MOSSI ROSA;GONZALEZ IBA脩EZ ROCIO;ROMERO CUENCA VICENTE;DURAN
03 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: DURAN DOUSSINAGUE BEATRIZ. Datos registrales. T 29264 , F 199, S 8, H M 98514, I/A 45(24.07.15).
21 de Agosto de 2014Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 29264 , F 199, S 8, H M 98514, I/A 44( 8.08.14).
16 de Agosto de 2013Reelecciones. Consejero: SILVELA SILVELA MARIA SONSOLES. Datos registrales. T 29264 , F 199, S 8, H M 98514, I/A 43 (7.08.13).
02 de Agosto de 2013Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 13潞. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina webcorporativa: www.decepal.com. Datos registrales. T 29264 , F 198, S 8, H M 98514, I/A 42 (25.07.13).
03 de Diciembre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: GEVASA SA. Datos registrales. T 29264 , F 195, S 8, H M 98514, I/A 41 (22.11.12).
03 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: JARILLO MOSSI ROSA. Presidente: MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA. Vicepresid.: OLAIZOLADE LAS CUEVAS MARIA ROSA. Consejero: MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA;OLAIZOLA DE LAS CUEVAS MARIAROSA;GRANDES CARCI MARIA JESUS;TOURNE ALEGRE BEATRIZ. Secretario: TOURNE ALEGRE BEATRIZ. VsecrNoConsj: GILMENDEZ BEATRIZ. Nombramientos. Consejero: GRANDES GARCI MARIA JESUS;MARTINEZ FERRANDO LUISMARIA;GONZALEZ OLIVAR CRISTINA;BENGURIA CALERA PABLO. Presidente: MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA. Vicepresid.:BENGURIA CALERA PABLO. Secretario: GIL MENDEZ BEATRIZ. Datos registrales. T 29264 , F 195, S 8, H M 98514, I/A 40(21.06.12).
03 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 59.739,40 Euros. Desembolsado: 59.739,40 Euros. Resultante Suscrito: 849.753,90 Euros.Resultante Desembolsado: 849.753,90 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 29264 , F 194, S 8, H M 98514, I/A 39 (24.01.12).
10 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 82.998,10 Euros. Desembolsado: 82.998,10 Euros. Resultante Suscrito: 790.014,50 Euros.Resultante Desembolsado: 790.014,50 Euros. Datos registrales. T 6025 , F 225, S 8, H M 98514, I/A 38 (28.12.11).
05 de Enero de 2012Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CENSORES ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 6025 , F 225, S 8, H M 98514, I/A 37(26.12.11).
20 de Diciembre de 2011Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: MAGATZEM SA. Datos registrales. T 6025 , F 222, S 8, H M 98514, I/A 36 (9.12.11).
12 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apoderado: OLAIZOLA DE LAS CUEVAS MARIA ROSA;LLOVET TAPIES EMILIA;HERAS OLIVER MARIAMERCEDES;LASA GOICOECHEA ICIAR;HERAS OLIVER MARIA MERCEDES;VALDES Y DE LA COLINA CLARA;SOMOLINOS DEJOVE MARIA;LASA GOICOECHEA ICIAR;HERAS OLIVER MARIA MERCEDES;SOMOLINOS DE JOVE MARIA;GONZALEZ IBA脩EZROCIO. Apo.Manc.: GONZALEZ IBA脩EZ ROCIO;GONZALEZ IBA脩EZ ROCIO. Apoderado: BLANCO PIMENTEL MONICA;BLANCOPIMENTEL MONICA. Datos registrales. T 6025 , F 222, S 8, H M 98514, I/A 35 (25.11.11).
07 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES ROJAS MARIA ANGUSTIAS. Datos registrales. T 6025 , F 221, S 8, H M 98514, I/A 34(24.11.11).
28 de Julio de 2011Otros conceptos: Datos identificativos de la Sociedad Absorbente "DECEPAL SA", NIF A-28954196,domiciliada en Madrid, calleAlbasanz 14 bis, RM al tomo 6026, folio 1 hoja M-98514.Sociedad Absorbida"MAGATZEM SA"NIF A-08917726,domiciliada enBarcelona, Avda de Pedralbes 8, RB al tomo 23.973, folio 54 hoja B-63714. Datos registrales. T 6025 , F 2, S 8, H M 98514, I/A 11M(15.07.11).
01 de Marzo de 2011Otros conceptos: NO VIGENCIA DE ASIENTO EN RELACION A LA SOCIEDAD "JANDILLA SA". Datos registrales. T 6025 , F218, S 8, H M 98514, I/A 32M (17.02.11).
20 de Diciembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 141.475,40 Euros. Desembolsado: 141.475,40 Euros. Resultante Suscrito: 707.016,40 Euros.Resultante Desembolsado: 707.016,40 Euros. Datos registrales. T 6025 , F 221, S 8, H M 98514, I/A 33 ( 3.12.10).
11 de Noviembre de 2010Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: JANDILLA SA. Datos registrales. T 6025 , F 218, S 8, H M 98514, I/A 32 (29.10.10).
15 de Julio de 2010Otros conceptos: JANDILLA SA, SOCIEDAD ABSORBIDA CON CIF NUM. A41274713 DOMICILIADA EN SEVILLA, CALLEBEATRIZ DE SUABIA NUMERO 58, BAJO, INSCRITA EN SEVILLA EN EL TOMO 1174, FOLIO 179, HOJA NUMERO 12223,INSCRIPCION 10.DECEPAL SA, SOCIEDAD ABSORBENTE, CON NIF A-28954196, DOMICILIADA EN MADRID CALLE ALBASANZNUMERO 14, BIS, INSCRITA EN EL TOMO 6025 , OBRANTE AL FOLIO 1 DE LA SECCION 8&, HOJA NUMERO 98514. Datosregistrales. T 6025 , F 1, S 8, H M 98514, I/A 11M ( 2.07.10).