Buscador CIF Logo

Actos BORME Dechra Veterinary Products Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Dechra Veterinary Products Sl

Actos BORME Dechra Veterinary Products Sl - B83353086

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Dechra Veterinary Products Sl con CIF B83353086

🔙 Perfil de Dechra Veterinary Products Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Dechra Veterinary Products Sl

18 de Diciembre de 2023
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 45595 , F 214, S 8, H B312222, I/A 29 ( 7.12.23).

15 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. CL DE TUSET 20, 6 (BARCELONA). Datos registrales. T 45595 , F 214, S 8, H B 312222, I/A 27 (

01 de Diciembre de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 45595 , F 213, S 8, H B312222, I/A 26 (24.11.21).

01 de Junio de 2021
Nombramientos. APODERAD.SOL: PAUL SANDLAND. Datos registrales. T 45595 , F 213, S 8, H B 312222, I/A 25 (21.05.21).

09 de Julio de 2020
Revocaciones. APODERAD.SOL: DEL BUSTO ALONSO JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 45595 , F 213, S 8, H B 312222,I/A 24 ( 1.07.20).

08 de Abril de 2020
Nombramientos. APODERAD.SOL: BRAZIS CAUBET PILAR. Datos registrales. T 45595 , F 212, S 8, H B 312222, I/A 23(27.03.20).

07 de Noviembre de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 45595 , F 212, S 8, H B312222, I/A 22 (29.10.19).

09 de Julio de 2018
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: IAN DAVID PAGE;ANTHONY GERARD GRIFFIN. Datos registrales. T 45595 , F 211, S 8, H B312222, I/A 21 (29.06.18).

27 de Junio de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: DEL BUSTO ALONSO JUAN ALFONSO. Datos registrales. T 45595 , F 211, S 8, H B 312222,I/A 20 (14.06.18).

31 de Marzo de 2017
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 45595 , F 211, S 8, H B312222, I/A 19 (24.03.17).

10 de Octubre de 2016
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: ANNE FRANCOISE NESMES. Datos registrales. T 37942 , F 167, S 8, H B 312222, I/A 18 (3.10.16).

09 de Mayo de 2014
Revocaciones. APODERADO: GOMEZ FRUCTUOSO FRANCISCO;ZABALA LOPEZ GOMEZ MARIA SOL;CHACON ECHEVARRIAIGNACIO;CHRISTINA BAHNSEN SKOU;CLAUS KORSAGER RIBER;HELLE TRONIER CHRISTIANSEN;LONE BAHNSENSKOU;SONJA DYRVIG;PIA PETERSEN;JORGEN EKER PETERSEN;BIRGIT INGEGERD AGGER;NIELS JUEL LARSEN. Datosregistrales. T 37942 , F 167, S 8, H B 312222, I/A 17 (28.04.14).

17 de Enero de 2014
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: SIMON DAVID EVANS;EDWIN TORR. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: ANTHONY GERARDGRIFFIN;IAN DAVID PAGE;ANNE FRANCOISE NESMES. Datos registrales. T 37942 , F 167, S 8, H B 312222, I/A 16 (10.01.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información