Actos BORME de Defex Sa Sme En Liquidacion
08 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP (EXTINGUIDA). Datos registrales. T 33171 , F 172, S 8, H M 43103, I/A 250 (1.02.22).
10 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Liquidador: COFIVACASA SA SME. Representan: PIPAON PULIDO JORGE GUILLERMO. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 1496/2019. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 25/09/2020. Auto de apertura de la fase deliquidaci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID. Juez: MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO.Datos registrales. T 33171 , F 172, S 8, H M 43103, I/A A (30.10.20).
06 de Febrero de 2020Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1496/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/10/2019. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID. Juez: MARIA TERESA VAZQUEZPIZARRO. Resoluciones: Se declara en situaci贸n legal de concurso -voluntario- a la entidad DEFEX SA. SME. EN LIQUIDACION, conCIF A-28293033, y domicilio en Avenida General Per贸n, n煤mero 38, Madrid. Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo2.463, folio 163, hoja M-43.103. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 1496/2019. Fecha de resoluci贸n 8/10/2019.Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID. Juez: MARIA TERESAVAZQUEZ PIZARRO. Administrador Concursal. Fecha 8/10/2019, NIF/CIF 36987707G. DOMENECH ORTI XAVIER. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 1496/2019. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 8/10/2019. Resoluciones acordando la intervenci贸n o
04 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 33171 , F 171, S 8, H M 43103, I/A 248 (27.11.19).
21 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: LORIENTE SAINZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: PIPAON PULIDOJORGE GUILLERMO. Datos registrales. T 33171 , F 171, S 8, H M 43103, I/A 247 (14.06.19).
12 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: ANDREANI CANO EMILIO;ENCINAS CHARRO JOSE IGNACIO;SANTA TERESA PINTORNATALIA;MORENO VIVAS JESUS;MORENO VIVAS JESUS. Apo.Manc.: VAZQUEZ ALVAREZ JOSE EMILIO;JIMENEZ NOTARIOMARIA ISABEL. Apoderado: SAEZ MARUGAN MARIA DEL ROSARIO. Apo.Manc.: LLORENS ALONSO FERNANDO. Apoderado:GONZALEZ IZQUIERDO QUINIDIO;GOMEZ CUESTA ENRIQUE FRANCISCO;VAZQUEZ ALVAREZ JOSE EMILIO;CONDEMONEDERO MARIA JESUS;JIMENEZ NOTARIO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 33171 , F 170, S 8, H M 43103, I/A 246 (5.02.19).
15 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP (EXTINGUIDA). Datos registrales. T 33171 , F 170, S 8, H M 43103, I/A 245 (8.01.19).
28 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Representan: GALVAN VALLINA MATILDE ENCARNACION. Nombramientos. Representan: LORIENTESAINZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33171 , F 170, S 8, H M 43103, I/A 244 (21.05.18).
07 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MAXAMCORP HOLDING ASSETS & SERVICES SL;TORRENTE SANCHEZ FRANCISCO;VILLAMIAUGARTE JUAN CARLOS. Presidente: VILLAMIA UGARTE JUAN CARLOS. Consejero: BOSCH JIMENEZ ANGELES;RAMOSTORIBIO ISABEL;ENRIQUEZ GONZALEZ NICOLAS;SAPA PLACENCIA SL;INSTALAZA SA. Representan: APERRIBAYBEDIALAUNETA IBON. SecreNoConsj: MORENO VIVAS JESUS. Representan: MU脩OZ BUENO LEONCIO;SALLENT ACEBOPEDRO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLAMIA UGARTE JUAN CARLOS. Nombramientos. Liquidador: COFIVACASA SA SME.Representan: GALVAN VALLINA MATILDE ENCARNACION. Disoluci贸n. Voluntaria. Datos registrales. T 33171 , F 169, S 8, H M43103, I/A 243 (27.10.17).