Buscador CIF Logo

Actos BORME Dekra Expertise Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Dekra Expertise Sl

Actos BORME Dekra Expertise Sl - B83854935

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Dekra Expertise Sl con CIF B83854935

馃敊 Perfil de Dekra Expertise Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Dekra Expertise Sl

17 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GERDON ROLAND MANFRIED. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLEJO SOROZABAL JUANMARIA. Apoderado: VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO;PAUL ROSA JESUS MARIA;CALLEJO SOROZABAL JUANMARIA;RAUH YVONNE;CALLEJO SOROZABAL JUAN MARIA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Extinci贸n. Datos registrales. T31087 , F 119, S 8, H M 348360, I/A 25 ( 6.10.17).

15 de Junio de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPAIN SL. Datos registrales. T 31087 , F119, S 8, H M 348360, I/A 24 ( 5.06.17).

08 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: CALLEJO SOROZABAL JUAN MARIA;MU脩OZ VARGAS AQUILINO;DEKRA AUTOMOTIVESOLUTIONS SPAIN SL. Vicepresid.: DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPAIN SL. Presidente: CALLEJO SOROZABAL JUANMARIA. Secretario: MU脩OZ VARGAS AQUILINO. Representan: SANCHEZ MARCOS. Nombramientos. Adm. Unico: GERDONROLAND MANFRIED. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 31087 , F 119, S 8, H M 348360, I/A 23 (31.01.17).

18 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: RAUH YVONNE;CALLEJO SOROZABAL JUAN MARIA. Datos registrales. T 31087 , F 117, S 8, H M348360, I/A 21 (10.01.17).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MU脩OZ VARGAS AQUILINO. Datos registrales. T 31087 , F 118, S 8, H M 348360, I/A 22 (10.01.17).

17 de Septiembre de 2015
Cambio de domicilio social. C/ FRANCISCO GERVAS 4 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 31087 , F 117, S 8, H M 348360,I/A 20 ( 9.09.15).

12 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: PAUL ROSA JESUS MARIA;CALLEJO SOROZABAL JUAN MARIA. Datos registrales. T 31087 , F117, S 8, H M 348360, I/A 19 ( 3.12.14).

04 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: NUNO DE SOUSA DIAS RICARDO. Nombramientos. Representan: SANCHEZ MARCOS.Datos registrales. T 31087 , F 116, S 8, H M 348360, I/A 18 (25.03.14).

06 de Febrero de 2014
Cambio de domicilio social. C/ ISLA DE HIERRO 7 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 31087 , F 116, S 8,H M 348360, I/A 17 (30.01.14).

03 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: FAUSTE DUQUE FERNANDO DAVID. Apo.Man.Soli: JUAN PICO ANTONIO;VIVO ROCAEDUARDO;SANCHEZ SALVADOR ALEJANDRO;FAUSTE DUQUE FERNANDO DAVID. Datos registrales. T 31087 , F 115, S 8, HM 348360, I/A 15 (21.11.13).

Nombramientos. Apoderado: VALENZUELA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO. Datos registrales. T 31087 , F 116, S 8, H M348360, I/A 16 (21.11.13).

19 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUAN PICO ANTONIO. Presidente: JUAN PICO ANTONIO. Consejero: VIVO ROCAEDUARDO;SANCHEZ SALVADOR ALEJANDRO. Vicepresid.: VIVO ROCA EDUARDO. Secretario: SANCHEZ SALVADORALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: CALLEJO SOROZABAL JUAN MARIA;MU脩OZ VARGAS AQUILINO;DEKRAAUTOMOTIVE SOLUTIONS SPAIN SL. Vicepresid.: DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS SPAIN SL. Presidente: CALLEJOSOROZABAL JUAN MARIA. Secretario: MU脩OZ VARGAS AQUILINO. Representan: NUNO DE SOUSA DIAS RICARDO. Datosregistrales. T 19787 , F 46, S 8, H M 348360, I/A 13 ( 7.08.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CALLEJO SOROZABAL JUAN MARIA;MU脩OZ VARGAS AQUILINO. Datos registrales. T 31087 , F115, S 8, H M 348360, I/A 14 ( 8.08.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n