Actos BORME de Dentix Health Corporation Sl
21 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: MASSO LOPEZ GUILLERMO;RIESGO GONZALEZ IGNACIO. Datos registrales. T 36227 , F 120, S8, H M 574365, I/A 28 (14.01.22).
10 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GOMEZ DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER. VsecrNoConsj: SANCHEZ HERRERO ENRIQUE.Datos registrales. T 36227 , F 120, S 8, H M 574365, I/A 27 (30.04.21).
03 de Febrero de 2021Nombramientos. Representan: MARTINEZ MARTINEZ ELISEO MANUEL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal1305/2020. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 20/11/2020. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal1305/2020. Fecha de resoluci贸n 30/11/2020. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 2 DE MADRID. Juez: ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 30/11/2020, NIF/CIF B86575685.ACCOUNT CONTROL-IUS&AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal1305/2020. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 20/11/2020. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades deadministraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez:ANDRES SANCHEZ MAGRO. Datos registrales. T 36227 , F 119, S 8, H M 574365, I/A A (28.01.21).
18 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ BARRIENTOS JESUS. Apoderado: DIAZ BARRIENTOS JESUS. Datos registrales. T 36227 , F 119,S 8, H M 574365, I/A 26 (11.12.20).
26 de Agosto de 2020Revocaciones. Apoderado: ANTON BRAVO DANIEL. Datos registrales. T 36227 , F 119, S 8, H M 574365, I/A 25 (19.08.20).
21 de Febrero de 2020Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Otros conceptos: REVOCADA LADESIGNACION DE "ETL GLOBAL AUDITORES DE CUENTAS SL" COMO AUDITOR DE LA SOCIEDAD PARA LOS EJERCICIOS2019 Y 2020. Datos registrales. T 36227 , F 119, S 8, H M 574365, I/A 24 (14.02.20).
22 de Enero de 2020Nombramientos. VsecrNoConsj: SANCHEZ HERRERO ENRIQUE. Datos registrales. T 36227 , F 118, S 8, H M 574365, I/A 23(15.01.20).
27 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL. Apoderado: RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL;RODRIGUEZPARTAL MARIA-ISABEL;SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 36227 , F 118, S 8, H M574365, I/A 22 (20.09.19).
10 de Junio de 2019Nombramientos. Auditor: ETL GLOBAL AUDITORES DE CUENTAS SL. Datos registrales. T 36227 , F 118, S 8, H M 574365, I/A21 ( 3.06.19).
19 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL;DOMINGUEZ MORENO LUIS MANUEL;MERLANO SOTOARTURO;ANTON BRAVO DANIEL;PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES;SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUELANGEL;MORATA NAVARRO MANUEL JOSE. Nombramientos. Consejero: RIESGO GONZALEZ IGNACIO. Modificacionesestatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Datos registrales. T 36227 , F 117, S 8, H M574365, I/A 20 (12.12.18).
24 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL;ALBIOL GUTIERREZ IGOR;DIAZ BARRIENTOSJESUS;PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES;SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL;ARMENDARIZ MOLINATANTONIO. Datos registrales. T 36227 , F 115, S 8, H M 574365, I/A 18 (17.10.18).
Revocaciones. Apoderado: BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA. Datos registrales. T 36227 , F 117, S 8, H M 574365, I/A 19(17.10.18).
12 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: CORRAL ARROYO ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 36227 , F 115, S 8, H M 574365, I/A 17 (4.07.18).
23 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: CORRAL ARROYO ANTONIO MIGUEL. Datos registrales. T 36227 , F 114, S 8, H M 574365, I/A 16(16.05.18).
19 de Abril de 2018Nombramientos. Consejero: SANCHEZ DE SEBASTIAN PINILLA MIGUEL ANGEL;MORATA NAVARRO MANUEL JOSE.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 36227 ,F 113, S 8, H M 574365, I/A 15 (11.04.18).
06 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ BARRIENTOS JESUS. Datos registrales. T 36227 , F 113, S 8, H M 574365, I/A 14 (26.02.18).
02 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LORENZO MURIEL ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ DOMINGUEZFRANCISCO JAVIER. Consejero: LORENZO MURIEL ANGEL;RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL;DOMINGUEZ MORENO LUISMANUEL;MERLANO SOTO ARTURO;ANTON BRAVO DANIEL;PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES;MASSO LOPEZGUILLERMO. Presidente: LORENZO MURIEL ANGEL. Con.Delegado: LORENZO MURIEL ANGEL. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION E INTRODUCCION DE ARTICULOS, Y APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. P谩ginaweb de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.dentix.com. Datos registrales. T 36227 , F 111, S 8, H M 574365,I/A 13 (25.10.17).
04 de Septiembre de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA. Datos registrales. T 31914 , F 106, S 8, H M 574365, I/A 11 (25.08.17).
Nombramientos. Apoderado: ANTON BRAVO DANIEL. Datos registrales. T 31914 , F 106, S 8, H M 574365, I/A 12 (25.08.17).
22 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: ROMERO JIMENEZ OSCAR. Datos registrales. T 31914 , F 106, S 8, H M 574365, I/A 10 (13.03.17).
11 de Enero de 2017Modificaciones estatutarias. 4. BIS. TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CREACION DE LOS ARTICULOS 4 BIS Y13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 31914 , F 106, S 8, H M 574365, I/A 9 ( 3.01.17).
30 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: PAPERAN SACCONE EDUARDO ANDRES. Datos registrales. T 31914 , F 105, S 8, H M 574365, I/A8 (22.12.16).
05 de Septiembre de 2016Nombramientos. Aud.C.Con.: OLSZEWSKI AUDITORES SL. Datos registrales. T 31914 , F 105, S 8, H M 574365, I/A 7 (26.08.16).
15 de Junio de 2016Nombramientos. Apoderado: ROMERO JIMENEZ OSCAR. Datos registrales. T 31914 , F 103, S 8, H M 574365, I/A 6 ( 8.06.16).
13 de Mayo de 2016Cambio de domicilio social. C/ RIBERA DEL LOIRA 56-58 - 2& PLANTA, ESCALERA DE (MADRID). Datos registrales. T 31914 ,F 103, S 8, H M 574365, I/A 5 ( 5.05.16).
28 de Diciembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 17.488.384,00 Euros. Resultante Suscrito: 17.491.384,00 Euros. Datos registrales. T 31914 , F 102,S 8, H M 574365, I/A 4 (16.12.15).
29 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL;BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA. Datos registrales. T 31914, F 102, S 8, H M 574365, I/A 3 (22.10.14).
04 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ PARTAL MARIA-ISABEL;BRAVO ESCUDERO ANA-MARIA. Datos registrales. T 31914 ,F 100, S 8, H M 574365, I/A 2 (26.06.14).
14 de Febrero de 2014Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.02.14. Objeto social: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAESTRATEGICA. Domicilio: AVDA DEL PARTENON, NUMERO CUATRO-SEIS, PRIMERA PLA (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: LORENZO MURIEL ANGEL. Nombramientos. Adm. Unico: LORENZO MURIELANGEL. Datos registrales. T 31914 , F 100, S 8, H M 574365, I/A 1 ( 7.02.14).