Buscador CIF Logo

Actos BORME Depureal 21 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Depureal 21 Sl

Actos BORME Depureal 21 Sl - B72155963

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Cadiz para Depureal 21 Sl con CIF B72155963

馃敊 Perfil de Depureal 21 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cadiz

Actos BORME de Depureal 21 Sl

10 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ARAGON ROMAN ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: MURIEL GALLARDO MANUELEDUARDO. Datos registrales. T 1998 , F 146, S 8, H CA 41276, I/A 7 (30.03.15).

Ceses/Dimisiones. Socio 煤nico: AGUAS DE PUERTO REAL SA. Gerente: TABOADA CORZO FELIX. SecreNoConsj: MURIELGALLARDO MANUEL EDUARDO. Consejero: DOMINGUEZ CARO FLORES;FERNANDEZ DIAZ MARIA ROCIO;IZCO REINAMANUEL JESUS;COSSI TORREJON MARGARITA;PEINADO PEREZ MARIA ISABEL;CANCA TORRES IVAN;MARTINEZ LOPEZJUAN CARLOS;BOY PECCI FERNANDO. Presidente: PEINADO PEREZ MARIA ISABEL. Revocaciones. Apoderado: TABOADACORZO FELIX. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1998 , F 146, S 8, H CA 41276, I/A 8 (30.03.15).

04 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALFARO BERENGUER JOSE. Datos registrales. T 1998 , F 145, S 8, H CA 41276, I/A 6 (27.08.14).

08 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JIMENEZ GUTIERREZ SAN MIGUEL FRANCISCO. Gerente: GASTARDI GUERRA MARIAROSARIO. Nombramientos. Gerente: TABOADA CORZO FELIX. SecreNoConsj: ARAGON ROMAN ANTONIO. Apoderado:TABOADA CORZO FELIX. Datos registrales. T 1998 , F 145, S 8, H CA 41276, I/A 4 (27.09.13).

Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRENTE FERNANDEZ ANA. Nombramientos. Consejero: ALFARO BERENGUER JOSE.Datos registrales. T 1998 , F 145, S 8, H CA 41276, I/A 5 (27.09.13).

03 de Octubre de 2013
Nombramientos. Consejero: PEINADO PEREZ MARIA ISABEL;IZCO REINA MANUEL JESUS;MARTINEZ LOPEZ JUANCARLOS;DOMINGUEZ CARO FLORES;BOY PECCI FERNANDO;FERNANDEZ DIAZ MARIA ROCIO;COSSI TORREJONMARGARITA;TORRENTE FERNANDEZ ANA;CANCA TORRES IVAN. Presidente: PEINADO PEREZ MARIA ISABEL. Datosregistrales. T 1998 , F 144, S 8, H CA 41276, I/A 3 (24.09.13).

13 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BARROSO TOLEDO JOSE ANTONIO. Presidente: BARROSO TOLEDO JOSE ANTONIO. Consejero:NORIA GARRUCHO ANTONIO;PARODI ALVAREZ SERGIO DOMINGO;ROMERO ARTIGAS PEDRO;PEINADO PEREZ MARIAISABEL;ALDAYTURRIAGA ALFARO JOSE ANTONIO;YESA HERRERA JESUS. Datos registrales. T 1998 , F 144, S 8, H CA 41276,I/A 2 ( 4.03.13).

03 de Febrero de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.12.09. Objeto social: a) La satisfacci贸n de las necesidades de la titularidad de laempresa en el campo de la depuraci贸n de las aguas residuales, constituyendo el servicioapropiado a tal fin en el seno de suorganizaci贸n administrativa, con el car谩cter de medio propio y servicio t茅cnico de la misma. b) La mejora de los. Domicilio: LUGAREDAR EL TROCADERO (PUERTO REAL). Capital: 12.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AGUAS DEPUERTO REAL SA. Nombramientos. Consejero: BARROSO TOLEDO JOSE ANTONIO. Presidente: BARROSO TOLEDO JOSEANTONIO. Consejero: NORIA GARRUCHO ANTONIO;PARODI ALVAREZ SERGIO DOMINGO;ROMERO ARTIGASPEDRO;PEINADO PEREZ MARIA ISABEL;ALDAYTURRIAGA ALFARO JOSE ANTONIO;YESA HERRERA JESUS. Gerente:GASTARDI GUERRA MARIA ROSARIO. SecreNoConsj: JIMENEZ GUTIERREZ SAN MIGUEL FRANCISCO. Datos registrales. T1998 , F 141, S 8, H CA 41276, I/A 1 (24.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n