Buscador CIF Logo

Actos BORME Deretil Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Deretil Sociedad Anonima

Actos BORME Deretil Sociedad Anonima - A08127631

Tenemos registrados 44 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Deretil Sociedad Anonima con CIF A08127631

馃敊 Perfil de Deretil Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Deretil Sociedad Anonima

15 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2064 , F 3, S 8, H AL 2853, I/A 164 ( 5.12.23).

19 de Julio de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTIN ALCOBER MIREIA. Datos registrales. T 2064 , F 2, S 8, H AL 2853, I/A 163 ( 7.07.23).

05 de Abril de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARROYO MARTINEZ ANTONIO;MARTIN ALCOBER MIREIA. Datos registrales. T 2064 , F 2, S 8,H AL 2853, I/A 162 (23.03.23).

06 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2064 , F 2, S 8, H AL 2853, I/A 161 (26.01.23).

03 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2064 , F 2, S 8, H AL 2853, I/A 160 (21.12.21).

13 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Adm. Unico: CONTROL Y GESTION INSTRUMENTAL SA. Datos registrales. T 2064 , F 1, S 8, H AL 2853, I/A 159(25.11.21).

15 de Julio de 2021
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2064 , F 1, S 8, H AL 2853, I/A 158 ( 7.07.21).

21 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARTIN ALCOBER MIREIA. Datos registrales. T 2064 , F 1, S 8, H AL 2853, I/A 157 (11.12.20).

24 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apoderado: FRONTERA MONTSERRAT GERARDO. Datos registrales. T 2064 , F 1, S 8, H AL 2853, I/A 156(12.02.20).

13 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 434 , F 225, S 8, H AL 2853, I/A 154 (5.02.20).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ SANCHEZ RAMON. Datos registrales. T 434 , F 225, S 8, H AL 2853, I/A 155 ( 5.02.20).

11 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 225, S 8, H AL 2853, I/A 153 ( 2.12.19).

25 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN ALCOBER MIREIA;BARRAL GUILLEM FERNANDO. Datos registrales. T 434 , F 224, S 8,H AL 2853, I/A 152 (15.03.19).

30 de Enero de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: SANTIANDREU LOPEZ RICARDO MANUEL;CANO GARCIA JOSE. Datos registrales. T 434 , F 223, S8, H AL 2853, I/A 149 (18.01.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: SANTIANDREU LOPEZ RICARDO MANUEL;GUTIERREZ SALMERON GRACIAN. Datos registrales.T 434 , F 223, S 8, H AL 2853, I/A 150 (18.01.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: BARRAL GUILLEM FERRAN;GUTIERREZ SALMERON GRACIAN;ARROYO MARTINEZ ANTONIO.Datos registrales. T 434 , F 223, S 8, H AL 2853, I/A 151 (22.01.19).

30 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 222, S 8, H AL 2853, I/A 148 (20.11.18).

29 de Noviembre de 2018
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-la fabricaci贸n de productos farmace煤ticos de base (CNAE2110), incluyendo la fabricaci贸n de amino谩cidos org谩nicos para la obtenci贸n de materias primas farmace煤ticas y, adicionalmente, laobtenci贸n de productos quimicos en general para otras aplicaciones. Cambio de objeto social. la fabricaci贸n de productosfarmace煤ticos de base (CNAE 2110), incluyendo la fabricaci贸n de amino谩cidos org谩nicos para la obtenci贸n de materias primasfarmace煤ticas y, adicionalmente, la obtenci贸n de productos quimicos en general para otras aplicaciones industriales. Datosregistrales. T 434 , F 222, S 8, H AL 2853, I/A 147 (19.11.18).

23 de Marzo de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CONTROL Y GESTION INSTRUMENTAL SA. Datos registrales. T 434 , F 222, S8, H AL 2853, I/A 146 (14.03.18).

23 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 222, S 8, H AL 2853, I/A 145 (14.11.17).

18 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: ARROYO MARTINEZ ANTONIO. Datos registrales. T 434 , F 221, S 8, H AL 2853, I/A 144 ( 4.05.17).

16 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: BARRAL GUILLEM FERNANDO. Datos registrales. T 434 , F 221, S 8, H AL 2853, I/A 143 ( 6.03.17).

30 de Diciembre de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 221, S 8, H AL 2853, I/A 142 (21.12.16).

17 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Adm. Unico: CONTROL Y GESTION INSTRUMENTAL SA. Datos registrales. T 434 , F 221, S 8, H AL 2853, I/A 141( 9.12.15).

26 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 220, S 8, H AL 2853, I/A 140 (18.11.15).

09 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 220, S 8, H AL 2853, I/A 139 (24.11.14).

21 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 220, S 8, H AL 2853, I/A 138 (11.11.13).

24 de Julio de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: CANO GARCIA JOSE;SANTIANDREU LOPEZ RICARDO MANUEL. Datos registrales. T 434 , F 220, S8, H AL 2853, I/A 137 (17.07.13).

28 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 220, S 8, H AL 2853, I/A 136 (21.01.13).

20 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 218, S 8, H AL 2853, I/A 135 ( 7.12.11).

17 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 218, S 8, H AL 2853, I/A 134 ( 3.01.11).

31 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ LOBACO LUIS;SANCHEZ RICO PALA RICARDO. Apo.Manc.: VAN DEN BERGJOHANNES;SANCHEZ SIEIRO ALBERTO;ANCHEZ SIERIO ALBERTO;VAN DEN BERG JOHANNES. Apoderado: BONILLARAMIREZ EWALDO. Apo.Manc.: SANCHEZ SIEIRO ALBERTO;VAN DEN BERG JOHANNES JAN W J;VAN DEN BERG JOHANNESJAN W J;MORALES MAGRAZO MANUEL;SANCHEZ RICO RICARDO. Datos registrales. T 434 , F 217, S 8, H AL 2853, I/A 133(19.05.10).

18 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 434 , F 217, S 8, H AL 2853, I/A 132 ( 5.01.10).

29 de Octubre de 2009
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SIEIRO ALBERTO. Apo.Manc.: MORALES MAGRAZO MANUEL. Apo.Man.Soli: BONETLLUIS FRANQUESA;MORALES MAGRAZO MANUEL;SANCHEZ SIEIRO ALBERTO. Apo.Manc.: MORALES MAGRAZOMANUEL;TRIGINER SALVAT GIL;SANCHEZ SIEIRO ALBERTO. Apo.Sol.: BONET LLUIS FRANQUESA. Apo.Manc.: MORALESMAGRAZO MANUEL;TRIGINER SALVAT GIL;CANO GARCIA JOSE;GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAMON;SANCHEZ SIEIROALBERTO;BONET LLUIS FRANQUESA. Datos registrales. T 434 , F 217, S 8, H AL 2853, I/A 131 (16.10.09).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARRAL GUILLEM FERNANDO. Apo.Manc.: BONET LLUIS FRANQUESA;MORALES MAGRAZOMANUEL. Datos registrales. T 434 , F 217, S 8, H AL 2853, I/A 130 (16.10.09).

29 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: JULIA DINARES JOAN. Consejero: CANO GARCIA JOSE;MORALES MAGRAZOMANUEL;TRIGINER SALVAT GIL;BONET LLUIS FRANQUESA;BONET LLUIS FRANQUESA;TRIGINER SALVAT GIL. Presidente:BONET LLUIS FRANQUESA. Secretario: VOLTA TORRAS ANTONIO;VOLTA TORRAS ANTONIO. VsecrNoConsj: LONGOMARTINEZ MARIA ROSARIO DE FATIMA. Nombramientos. Adm. Unico: CONTROL Y GESTION INSTRUMENTAL SA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 434 , F 175, S 8, H AL 2853, I/A 127 (16.09.09).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BONET LLUIS FRANQUESA;MORALES MAGRAZO MANUEL;TRIGINER SALVAT GIL;CANOGARCIA JOSE. Datos registrales. T 434 , F 175, S 8, H AL 2853, I/A 33 (17.09.09).

Nombramientos. Apoderado: LONGO MARTINEZ MARIA ROSARIO DE FATIMA;VOLTA TORRAS ANTONIO. Datos registrales. T434 , F 217, S 8, H AL 2853, I/A 34 (17.09.09).

21 de Abril de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: SANTIANDREU LOPEZ RICARDO MANUEL;CANO GARCIA JOSE. Datos registrales. T 434 , F 174,S 8, H AL 2853, I/A 125 ( 8.04.09).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 434 , F 174, S 8, H AL 2853, I/A 126 (8.04.09).

02 de Abril de 2009
Revocaciones. Apo.Manc.: CANO GARCIA JOSE;PORSKAMP PASCHALIS;NAVARRO GIMENEZ CONSUELO;MARTINEZCARRE脩O JOSE LUIS. Apoderado: GARCIA SANCHEZ RAFAEL RAMON. Datos registrales. T 434 , F 174, S 8, H AL 2853, I/A 124(24.03.09).

01 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: CANO GARCIA JOSE. Datos registrales. T 434 , F 174, S 8, H AL 2853, I/A 122 (20.03.09).

Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ MARQUEZ ANTONIO;SANTIANDREU LOPEZ RICARDO MANUEL;NAVARROGIMENEZ CONSUELO;CANO GARCIA JOSE. Datos registrales. T 434 , F 174, S 8, H AL 2853, I/A 123 (20.03.09).

13 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: BONET LLUIS FRANQUESA;MORALES MAGRAZO MANUEL. Datos registrales. T 434 , F 173, S 8,H AL 2853, I/A 121 ( 4.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n