Actos BORME de Desarrollo Online Juegos Regulados Sa
21 de Noviembre de 2019Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 27287 , F 211, S 8, H M 491614, I/A 23 (14.11.19).
28 de Septiembre de 2018Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 21陋 EL NOMBRAMIENTO DE 2 CONSEJEROS, SIENDO LOCORRECTO ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. Datos registrales. T 27287 , F 211, S 8, H M 491614, I/A 21 (12.06.18).
14 de Agosto de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CODERE OPERADORAS DE APUESTAS SL. Datos registrales. T27287 , F 211, S 8, H M 491614, I/A 22 ( 6.08.18).
19 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JIMENEZ MARQUEZ DAVID;DI LORETO VICENTE;PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO.Nombramientos. Consejero: CORZO UCEDA ANGEL;DE ANSORENA CAO ALVARO. Datos registrales. T 27287 , F 211, S 8, H M491614, I/A 21 (12.06.18).
10 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;OFICIALDEGUI ATIN JONAS.Datos registrales. T 27287 , F 211, S 8, H M 491614, I/A 20 ( 3.04.18).
22 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION. Nombramientos. Adm. Solid.: JIMENEZ MARQUEZDAVID;DI LORETO VICENTE;PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T 27287 , F 210, S 8, H M 491614, I/A 19 (15.03.18).
18 de Marzo de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;MARTINEZ QUEROJESUS;LOPEZ ZAFRA JACOBO. Datos registrales. T 27287 , F 209, S 8, H M 491614, I/A 18 ( 9.03.16).
23 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO;GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T27287 , F 209, S 8, H M 491614, I/A 17 (12.06.15).
05 de Junio de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ CORTIJO ROCIO ALEJANDRA;ALVAREZ DE NEYRA RODRIGUEZ JAIME. Datos registrales.T 27287 , F 209, S 8, H M 491614, I/A 16 (27.05.15).
02 de Febrero de 2015Revocaciones. Apoderado: RODRIGO GOMEZ OLGA MARIA;ESTALELLA CARVAJAL JAIME. Datos registrales. T 27287 , F 209,S 8, H M 491614, I/A 15 (26.01.15).
17 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;PASCUAL GONZALEZ ALEJANDRO;QUEIRO AMEIJEIRASMANUEL;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO;GONZALEZ LAINEZ JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 27287 , F 208, S 8, H M 491614, I/A 14 ( 9.12.14).
01 de Agosto de 2014Nombramientos. Apoderado: PEREZ PEREZ JUAN-MIGUEL;GONZALEZ REDONDO ANGEL;TABERNER BENAGES FRANCISCO.Datos registrales. T 27287 , F 208, S 8, H M 491614, I/A 13 (24.07.14).
04 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL;VIDAL MESA FERNANDO. Datos registrales. T 27287 , F 207, S8, H M 491614, I/A 12 (25.06.14).
23 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: PARA ANDRADE ANTONIO. Datos registrales. T 27287 , F 207, S 8, H M 491614, I/A 11 (12.06.14).
03 de Abril de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CODERE ONLINE SA. Datos registrales. T 27287 , F 206, S 8, H M491614, I/A 10 (26.03.14).
14 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ SAMPEDRO LUIS JAVIER. Presidente: MARTINEZ SAMPEDRO LUIS JAVIER.Consejero: CORTIJO FERNANDEZ MARIA CRISTINA;SANCHEZ CORTIJO ROCIO ALEJANDRA. Cons.Del.Sol: MARTINEZSAMPEDRO LUIS JAVIER;CORTIJO FERNANDEZ MARIA CRISTINA. SecreNoConsj: PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO.Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ SAMPEDRO ENCARNACION. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION PARCIALDE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambiode domicilio social. AVDA DE BRUSELAS, N潞 26 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 27287 , F 10, S 8, H M 491614, I/A 8 (6.03.14).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGO GOMEZ OLGA MARIA;PARA ANDRADE ANTONIO;ESTALELLA CARVAJALJAIME;QUEIRO AMEIJEIRAS MANUEL. Datos registrales. T 27287 , F 206, S 8, H M 491614, I/A 9 ( 6.03.14).
20 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CATALA POLO RAFAEL. Secretario: CATALA POLO RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj:PARRA CEBEIRA JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 27287 , F 9, S 8, H M 491614, I/A 7 ( 8.02.12).
26 de Diciembre de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CODERE SA. Datos registrales. T 27287 , F 9, S 8, H M 491614, I/A 6 (14.12.11).
13 de Diciembre de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 286.750,01 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5.Capital.-. Datos registrales. T 27287 , F 8, S 8, H M 491614, I/A 5 (29.11.10).
28 de Septiembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 752.751,00 Euros. Desembolsado: 466.000,99 Euros. Resultante Suscrito: 1.752.751,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.466.000,99 Euros. Datos registrales. T 27287 , F 7, S 8, H M 491614, I/A 4 (14.09.10).
05 de Mayo de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 750.000,00 Euros. Datos registrales. T 27287 , F 7, S 8, H M 491614, I/A 3(23.04.10).
20 de Enero de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.12.09. Objeto social: EXPLOTACION MEDIANTE MAQUINAS RECREATIVAS, JUEGOSDE MESAS, AZAR;. Domicilio: C/ MANISES 3 - 3潞 IZQUIERDA Y BAJO (POZUELO DE ALARCON). Capital suscrito: 1.000.000,00
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ CORTIJO ROCIO ALEJANDRA;ALVAREZ DE NEYRA RODRIGUEZ JAIME. Datosregistrales. T 27287 , F 6, S 8, H M 491614, I/A 2 ( 8.01.10).