Actos BORME de Desarrollo Vivienda Pozuelo Oeste 2 Sl
22 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMILLERI TERRER LUIS;HERNANDO REVUELTA ANDRES;PABLOS MAYORDOMO MARIA
10 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: BORRAJO NOVOA MANUEL. Consejero: BORRAJO NOVOA MANUEL. Nombramientos.Presidente: CAMILLERI TERRER LUIS. Datos registrales. T 25216 , F 116, S 8, H M 454109, I/A 8 ( 2.01.20).
09 de Mayo de 2013Reducción de capital. Importe reducción: 2.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.296.760,00 Euros. Otros conceptos:RENUMERADAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL 1 AL 1.296.760, AMBAS INCLUSIVE, MODIFICANDO EL ARTICULO 5ºDE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 25216 , F 115, S 8, H M 454109, I/A 7 (26.04.13).
11 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: ORTIZ SEIJAS MARIA. Datos registrales. T 25216 , F 115, S 8, H M 454109, I/A 6 ( 1.03.10).
10 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LA GUIA NIETO JOSE ADRIAN. Presidente: DE LA GUIA NIETO JOSE ADRIAN. Cons.Del.Sol:DE LA GUIA NIETO JOSE ADRIAN. Secretario: BORRAJO NOVOA MANUEL. Nombramientos. Consejero: HERNANDOREVUELTA ANDRES;PABLOS MAYORDOMO MARIA CONCEPCION. Presidente: BORRAJO NOVOA MANUEL. Secretario:PABLOS MAYORDOMO MARIA CONCEPCION. Datos registrales. T 25216 , F 114, S 8, H M 454109, I/A 5 (26.02.10).
30 de Julio de 2009Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 4º. Domicilio Social. Cambio de domicilio social. C/ GUSTAVOFERNANDEZ BALBUENA NUMERO 11 (MADRID). Datos registrales. T 25216 , F 114, S 8, H M 454109, I/A 4 (17.07.09).
02 de Abril de 2009Ampliación de capital. Capital: 223.380,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.298.760,00 Euros. Datos registrales. T 25216 , F 112, S 8,H M 454109, I/A 3 (24.03.09).