Actos BORME de Desarrollos Industriales Sora Sl
24 de Octubre de 2022Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3818 , F 208, S 8, H Z 29669, I/A 47 (17.10.22).
25 de Julio de 2019Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 3818 , F 208, S 8, H Z 29669, I/A 46 (18.07.19).
10 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: U V E SOCIEDAD ANONIMA. Vicepresid.: U V E SOCIEDAD ANONIMA. Presidente: MOLINEROPOZA FRANCISCO. Consejero: GARCIA CIUDAD MARIA DEL CARMEN;CAUDEVILLA GARCIA JAVIER. Secretario: GARCIACIUDAD MARIA DEL CARMEN. Consejero: MOLINERO POZA FRANCISCO;ZUECO RUIZ MIGUEL. Nombramientos. Consejero: UV E SOCIEDAD ANONIMA;GOMEZ ARRANZ RAUL;JIMENEZ CACHO MIGUEL ANGEL. Presidente: U V E SOCIEDAD ANONIMA.Vicepresid.: GOMEZ ARRANZ RAUL. Secretario: JIMENEZ CACHO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3818 , F 206, S 8, H Z29669, I/A 44 ( 3.12.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: UVE SA. Apo.Manc.: GOMEZ ARRANZ RAUL;JIMENEZ CACHO MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 3818 , F 207, S 8, H Z 29669, I/A 45 ( 3.12.18).
31 de Octubre de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLASCO DIESTE LORENA. Datos registrales. T 3818 , F 206, S 8, H Z 29669, I/A 43 (24.10.17).
05 de Diciembre de 2016Reelecciones. Auditor: AUREN AUDITORES ZAZ SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 3818 , F 206, S 8, HZ 29669, I/A 42 (25.11.16).
11 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CAUDEVILLA PUYOD JULIAN;ALAYETO AGUARON LUIS GONZALO. Secretario: ALAYETOAGUARON LUIS GONZALO. Nombramientos. Consejero: GARCIA CIUDAD MARIA DEL CARMEN;CAUDEVILLA GARCIA JAVIER.Secretario: GARCIA CIUDAD MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 3818 , F 205, S 8, H Z 29669, I/A 41 (30.10.15).
26 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA RURAL DE ARAGON S. COOP. DE CREDITO EN LIQUID. Datos registrales. T 3818 , F 205,S 8, H Z 29669, I/A 39 (16.01.12).
06 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MENA GERICO JUAN JOSE. Datos registrales. T 3818 , F 205, S 8, H Z 29669, I/A 38 (27.09.11).
23 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MENA GERICO JESUS. Presidente: MENA GERICO JESUS. Revocaciones. Apo.Manc.: MENAGERICO JESUS;U V E SOCIEDAD ANONIMA;ALAYETO AGUARON JOSE ANTONIO;CAUDEVILLA PUYOD JULIAN;MENA GERICOJUAN JOSE;CAJA RURAL DE ARAGON S. COOP. DE CREDITO;ALAYETO AGUARON JOSE ANTONIO;CAUDEVILLA PUYODJULIAN;MENA GERICO JESUS;MENA GERICO JUAN JOSE;U V E SOCIEDAD ANONIMA;ZUECO RUIZ MIGUEL;MOLINERO POZAFRANCISCO;ALAYETO AGUARON LUIS GONZALO. Nombramientos. Presidente: MOLINERO POZA FRANCISCO. Datosregistrales. T 3818 , F 204, S 8, H Z 29669, I/A 36 (13.09.11).
Nombramientos. Director: LARRODE ANTO脩ANZAS ISABEL. Apo.Man.Soli: LARRODE ANTO脩ANZAS ISABEL. Apo.Manc.: U V ESOCIEDAD ANONIMA;ALAYETO AGUARON LUIS GONZALO;CAJA RURAL DE ARAGON S. COOP. DE CREDITO;CAUDEVILLAPUYOD JULIAN;ZUECO RUIZ MIGUEL;MENA GERICO JUAN JOSE. Apo.Man.Soli: MOLINERO POZA FRANCISCO. Datosregistrales. T 3818 , F 205, S 8, H Z 29669, I/A 37 (13.09.11).
25 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: ALAYETO AGUARON JOSE ANTONIO. Consejero: ALAYETO AGUARON JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 3493 , F 83, S 8, H Z 29669, I/A 34 (12.01.11).
Nombramientos. Consejero: ALAYETO AGUARON LUIS GONZALO. Secretario: ALAYETO AGUARON LUIS GONZALO. Apo.Manc.:ALAYETO AGUARON LUIS GONZALO. Datos registrales. T 3493 , F 83, S 8, H Z 29669, I/A 35 (12.01.11).
19 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ DIEZ MANUEL. Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ DIEZ MANUEL.Nombramientos. Consejero: MOLINERO POZA FRANCISCO. Apo.Manc.: MOLINERO POZA FRANCISCO. Datos registrales. T3493 , F 82, S 8, H Z 29669, I/A 33 ( 5.11.10).
15 de Julio de 2010Otros conceptos: Cambiado el representante del Consejero y Vicepresidente del Consejo "DESARROLLOS INDUSTRIALES SORA,SL", siendo el actual Don Ra煤l G贸mez Arranz. Datos registrales. T 3493 , F 82, S 8, H Z 29669, I/A 32 ( 6.07.10).
07 de Junio de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 403.191,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.165.572,00 Euros. Datos registrales. T 3493 , F 82, S 8, HZ 29669, I/A 31 (25.05.10).
25 de Marzo de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.850,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.762.381,00 Euros. Datos registrales. T 3493 , F 82, S 8, HZ 29669, I/A 30 (15.03.10).
11 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 456.619,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.644.531,00 Euros. Datos registrales. T 3493 , F 81, S 8, HZ 29669, I/A 28 (29.12.09).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.749.531,00 Euros. Datos registrales. T 3493 , F 81, S 8, HZ 29669, I/A 29 (29.12.09).
07 de Julio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 477.479,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.082.912,00 Euros. Datos registrales. T 3493 , F 80, S 8, HZ 29669, I/A 24 (25.06.09).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 105.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.187.912,00 Euros. Datos registrales. T 3493 , F 81, S 8, HZ 29669, I/A 25 (25.06.09).
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL VALDEFERRIN CENTRO DE NEGOCIOS EX (ZARAGOZA). Cambio de objetosocial. Explotaciones agr铆colas y ganaderas, as铆 como la producci贸n, comercializaci贸n, importaci贸n y exportaci贸n de los productosderivados de dichas explotaciones. La realizaci贸n de inversiones y el ejercicio de actividades agrarias fomentadoras de la protecci贸ndel medio ambiente, el tratamiento org谩nico. Datos registrales. T 3493 , F 81, S 8, H Z 29669, I/A 26 (25.06.09).