Buscador CIF Logo

Actos BORME Detea Corporacion Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Detea Corporacion Sl

Actos BORME Detea Corporacion Sl - B91787507

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Sevilla para Detea Corporacion Sl con CIF B91787507

馃敊 Perfil de Detea Corporacion Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Sevilla

Actos BORME de Detea Corporacion Sl

03 de Octubre de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;RIVAS GIL MARIA DE LA O;PE脩A LOPEZ PAZO JUAN;BARBAGALVEZ ANTONIO. Apo.Manc.: MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;PULIDO GARCIA VICTOR;ROMERO DONOSO ALVAROLUIS;PE脩A LOPEZ PAZO JUAN;RIVAS GIL MARIA DE LA O;PULIDO GARCIA VICTOR;BARBA GALVEZ ANTONIO;ROMERODONOSO ALVARO LUIS;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;PI脩ERO GONZALEZ DE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DELA O;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;PE脩A LOPEZ PAZO JUAN;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;PI脩ERO GONZALEZDE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DE LA O;PE脩A LOPEZ PAZO JUAN;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;MORENOSERRALLE LUIS ALBERTO;PI脩ERO GONZALEZ DE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DE LA O;MORENO SERRALLE LUISALBERTO;BARBA GALVEZ ANTONIO;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;BARBA GALVEZ ANTONIO;PI脩ERO GONZALEZ DELA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DE LA O;BARBA GALVEZ ANTONIO;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO. Apo.Sol.: BARBAGALVEZ ANTONIO. Otros conceptos: Quedan REVOCADOS todos los poderes como consecuenecia de la EXTINCION. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 713/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 18/07/2016. Auto de conclusi贸n del concurso.Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZLOPEZ. Resoluciones: CONCLUSION DEL CONCURSO, EL CESE DE LA LIMITACION DE FACULTADES,. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 713/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 18/07/2016. Cese de las limitaciones de las facultades deadministraci贸n. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 713/2012. Fecha de resoluci贸n 29/06/2012. Revocaci贸n de administradores concursales.Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal.Fecha 18/07/2016, NIF/CIF B91972604. INTEGRA SERVICIOS CONCURSALES S L P. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 713/2012. Fecha de resoluci贸n 19/06/2012. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 18/07/2016, NIF/CIF B91818260.SANCHEZ MEJIAS & TATO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal713/2012. Fecha de resoluci贸n 19/06/2012. Revocaci贸n de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 18/07/2016, NIF/CIF B91972604.INTEGRA SERVICIOS CONCURSALES S L P. Extinci贸n. Datos registrales. T 5065 , F 111, S 8, H SE 81230, I/A 27 (26.09.16).

26 de Agosto de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: CHACON CARMONA ROCIO. Apoderado: BUSTO MATA GREGORIO MANUEL. Datos registrales. T5065 , F 109, S 8, H SE 81230, I/A 22 (19.08.13).

24 de Julio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO DONOSO ALVARO LUIS. Apo.Sol.: ROMERO DONOSO ALVARO LUIS;ROMERO DONOSOALVARO LUIS. Datos registrales. T 5065 , F 109, S 8, H SE 81230, I/A 21 (12.07.13).

22 de Mayo de 2013
Nombramientos. Aud.C.Con.: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 5065 , F 109, S 8, H SE 81230, I/A 20 ( 9.05.13).

19 de Julio de 2012
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 713/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 19/06/2012. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ.Resoluciones: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 713/2012. FIRME:Si, Fecha de resoluci贸n 19/06/2012. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n ydisposici贸n del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 713/2012. Fecha de resoluci贸n 29/06/2012. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal.Fecha 29/06/2012, NIF/CIF B91972604. INTEGRA SERVICIOS CONCURSALES S L P. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 713/2012. Fecha de resoluci贸n 19/06/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA. Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 19/06/2012, NIF/CIF B91818260.SANCHEZ MEJIAS & TATO AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 713/2012. Fechade resoluci贸n 19/06/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞 1 DE SEVILLA.Juez: EDUARDO GOMEZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 19/06/2012, NIF/CIF B91972604. INTEGRA SERVICIOSCONCURSALES S L P. Datos registrales. T 5065 , F 107, S 8, H SE 81230, I/A 19 (29.06.12).

21 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID MARIA TERESA. Co.De.Ma.So: CONFIACE INGENIEROSY ASESORES SOCIEDAD LIMITADA;GONZALO YBARRA FRANCISCO JAVIER Nombramientos. Consejero: MORENO SERRALLELUIS ALBERTO. Con.Delegado: CONFIACE INGENIEROS Y ASESORES SOCIEDAD LIMITADA. Reelecciones. SecreNoConsj:BASA YBARRA EDUARDO. Datos registrales. T 5065 , F 107, S 8, H SE 81230, I/A 18 ( 7.03.12).

24 de Febrero de 2012
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5065 , F 106, S 8, H SE 81230, I/A 17 ( 7.02.12).

18 de Noviembre de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: PULIDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: PULIDO GARCIA VICTOR;PULIDO GARCIA VICTOR. Apo.Sol.:PULIDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: PULIDO GARCIA VICTOR. Datos registrales. T 5065 , F 106, S 8, H SE 81230, I/A 16 (2.11.11).

21 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: BUSTO MATA GREGORIO MANUEL. Datos registrales. T 5065 , F 104, S 8, H SE 81230, I/A 15 (8.03.11).

01 de Junio de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 81.140,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.172.140,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 5065 , F 104, S 8, H SE 81230, I/A 14 (18.05.10).

07 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: PULIDO GARCIA VICTOR. Datos registrales. T 5065 , F 101, S 8, H SE 81230, I/A 11 (25.11.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO DONOSO ALVARO LUIS. Datos registrales. T 5065 , F 102, S 8, H SE 81230, I/A 12(25.11.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: BARBA GALVEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5065 , F 103, S 8, H SE 81230, I/A 13 (25.11.09).

24 de Noviembre de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 290.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.091.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 5065 , F 101, S 8, H SE 81230, I/A 10 ( 5.11.09).

11 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Auditor: ERNEST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5065 , F 100, S 8, H SE 81230, I/A 9 ( 2.09.09).

13 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO. Apo.Manc.: MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO;PULIDOGARCIA VICTOR;ROMERO DONOSO ALVARO LUIS;PE脩A LOPEZ PAZO JUAN. Datos registrales. T 5013 , F 52, S 8, H SE81230, I/A 2 (29.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: RIVAS GIL MARIA DE LA O. Apo.Manc.: RIVAS GIL MARIA DE LA O;PULIDO GARCIA VICTOR;PE脩ALOPEZ PAZO JUAN;BARBA GALVEZ ANTONIO;ROMERO DONOSO ALVARO LUIS. Datos registrales. T 5013 , F 55, S 8, H SE81230, I/A 3 (29.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: CHACON CARMONA ROCIO. Datos registrales. T 5013 , F 56, S 8, H SE 81230, I/A 4 (29.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO DONOSO ALVARO LUIS. Apo.Manc.: ROMERO DONOSO ALVARO LUIS;MORENOSERRALLE LUIS ALBERTO;ROMERO DONOSO ALVARO LUIS;PI脩ERO GONZALEZ DE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DELA O;ROMERO DONOSO ALVARO LUIS;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 5013 , F 57, S 8, H SE 81230,I/A 5 (29.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: PE脩A LOPEZ PAZO JUAN. Apo.Manc.: PE脩A LOPEZ PAZO JUAN;MORENO SERRALLE LUISALBERTO;PE脩A LOPEZ PAZO JUAN;PI脩ERO GONZALEZ DE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DE LA O;PE脩A LOPEZ PAZOJUAN;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 5013 , F 59, S 8, H SE 81230, I/A 6 (30.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: PULIDO GARCIA VICTOR. Apo.Manc.: PULIDO GARCIA VICTOR;MORENO SERRALLE LUISALBERTO;PULIDO GARCIA VICTOR;PI脩ERO GONZALEZ DE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DE LA O;PULIDO GARCIAVICTOR;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 5065 , F 96, S 8, H SE 81230, I/A 7 (30.04.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: BARBA GALVEZ ANTONIO. Apo.Manc.: BARBA GALVEZ ANTONIO;MORENO SERRALLE LUISALBERTO;BARBA GALVEZ ANTONIO;PI脩ERO GONZALEZ DE LA PE脩A CARLOS;RIVAS GIL MARIA DE LA O;BARBA GALVEZANTONIO;MORENO SERRALLE LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 5065 , F 97, S 8, H SE 81230, I/A 8 (30.04.09).

20 de Enero de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 16.12.08. Objeto social: La direcci贸n y gesti贸n de valores representativos de los fondospropios desociedades y otras entidades; y la prestaci贸n de servicios de asesoramiento y apoyo de entidades participadas. Domicilio: C/ALBERT EINSTEIN 8 - PABELLON DE CHILE.- (SEVILLA). Capital: 5.381.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GONZALOYBARRA FRANCISCO JAVIER. Presidente: GONZALO YBARRA FRANCISCO JAVIER. Consejero: CONFIACE INGENIEROS YASESORES SOCIEDAD LIMITADA. Co.De.Ma.So: CONFIACE INGENIEROS Y ASESORES SOCIEDAD LIMITADA. Consejero:GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID MARIA TERESA. Co.De.Ma.So: GONZALO YBARRA FRANCISCO JAVIER. SecreNoConsj:BASA YBARRA EDUARDO. Datos registrales. T 5013 , F 50, S 8, H SE 81230, I/A 1 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n