Buscador CIF Logo

Actos BORME Detriavall Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Detriavall Sl

Actos BORME Detriavall Sl - B65427213

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Detriavall Sl con CIF B65427213

馃敊 Perfil de Detriavall Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Detriavall Sl

20 de Octubre de 2021
Modificaciones estatutarias. Creaci贸n de un nuevo art铆culo 7潞 bis y modificaci贸n del art铆culo 10潞 de los estatutos sociales. . Datosregistrales. T 36890 , F 58, S 8, H M 660012, I/A 6 (13.10.21).

20 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ RUBIO NURIA;GALLETTO ALESSANDRO;GALLETTO ALESSANDRO. Datos registrales. T36890 , F 57, S 8, H M 660012, I/A 4 (12.12.18).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ RUBIO NURIA. Datos registrales. T 36890 , F 57, S 8, H M 660012, I/A 5 (12.12.18).

04 de Junio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ALVAREZ MANUEL. Con.Delegado: MARTINEZ ALVAREZ MANUEL. Presidente:MARTINEZ ALVAREZ MANUEL. Consejero: MARTINEZ NAVARRO CRISTIAN;MARTINEZ NAVARRO MARCOS. Secretario:MARTINEZ NAVARRO CRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINEZ ALVAREZ MANUEL. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 36890 , F 57, S 8, H M 660012, I/A3 (28.05.18).

27 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ PRINCESA 25-27 2陋 - OFICINA NUMERO 8 (MADRID). Datos registrales. T 36890 , F 57, S 8, H M660012, I/A 2 (19.12.17).

11 de Octubre de 2016
Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,CONSULTORIA Y DE APOYO A LAGESTION A TERCEROS EN AREAS -ENTRE OTRAS- COMO LA DIRECCION GENERAL,DIRECCION FINANCIERA,RECURSOSHUMANOS,MARKETING,INFORMATICA Y SISTEMAS. ... Datos registrales. T 42211 , F 59, S 8, H B 404218, I/A 7 ( 3.10.16).

22 de Febrero de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: ALESSANDRO GALLETTO. Datos registrales. T 42211 , F 58, S 8, H B 404218, I/A 5

Nombramientos. APOD.MANCOMU: ALESSANDRO GALLETTO;SANCHEZ RUBIO NURIA. Datos registrales. T 42211 , F 59, S 8,H B 404218, I/A 6 (11.02.16).

20 de Mayo de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHEZ RUBIO NURIA. Datos registrales. T 42211 , F 58, S 8, H B 404218, I/A 4 (11.05.15).

07 de Junio de 2012
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL 453 BIS ATICO (BARCELONA). Datos registrales. T 42211 , F 58, S 8, H B 404218,I/A 3 (24.05.12).

08 de Abril de 2011
Otros conceptos: ABSORCION DE PATRIMONIO PROVENIENTE DE LA ESCISION PARCIAL DE LA SOCIEDAD "ASISTENCIADENTAL EUROPEA SA" (SOCIEDAD UNIPERSONAL). Datos registrales. T 42211 , F 56, S 8, H B 404218, I/A 2 (28.03.11).

03 de Diciembre de 2010
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.10.10. Objeto social: LA TENENCIA,ADMINISTRACION,COMPRA Y VENTA DEACTIVOS,PARTICIPACIONES,ACCIONES,TITULOS Y TODO TIPO DE VALORES MOBILIARIOS. Domicilio: CL TUSET Num.18 P.2PTA.2 (BARCELONA). Capital: 59.540.725,00 Euros. Nombramientos. CONSEJERO: MARTINEZ ALVAREZ MANUEL.PRESIDENTE: MARTINEZ ALVAREZ MANUEL. CONS. DELEG.: MARTINEZ ALVAREZ MANUEL. CONSEJERO: MARTINEZNAVARRO CRISTIAN. SECRETARIO: MARTINEZ NAVARRO CRISTIAN. CONSEJERO: MARTINEZ NAVARRO MARCOS. Datosregistrales. T 42211 , F 53, S 8, H B 404218, I/A 1 (22.11.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n