Actos BORME de Deva 98 Sl
06 de Mayo de 2019Revocaciones. ADMINISTR.: VAZQUEZ RUIZ DEL ARBOL CARLOS. ADM.SOLIDAR.: MENSA PUEYO JORDI. LIQUIDADOR:BAGES FARRE JOSE MARIA. Nombramientos. LIQUIDADOR: BAGES FARRE JOSE MARIA. Extinci贸n. Datos registrales. T34943 , F 219, S 8, H B 177281, I/A 12 (24.04.19).
21 de Febrero de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.137.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 284.400,00 Euros. Datos registrales. T 34943 ,F 218, S 8, H B 177281, I/A 11 (13.02.19).
14 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 600.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.422.000,00 Euros. Datos registrales. T 34493 , F 217, S 8,H B 177281, I/A 10 ( 2.02.11).
19 de Octubre de 2010Modificaciones estatutarias. ART.7.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 34943 , F 217, S 8, H B 177281, I/A 9 ( 6.10.10).
28 de Octubre de 2009Revocaciones. ADMINISTR.: FAJARDO LOPEZ FERNANDO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MENSA PUEYO JORDI. Datosregistrales. T 34943 , F 216, S 8, H B 177281, I/A 8 (16.10.09).