Buscador CIF Logo

Actos BORME Diagonal Mar Propco 1 Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Diagonal Mar Propco 1 Sl

Actos BORME Diagonal Mar Propco 1 Sl - B62803523

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Diagonal Mar Propco 1 Sl con CIF B62803523

🔙 Perfil de Diagonal Mar Propco 1 Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Diagonal Mar Propco 1 Sl

03 de Octubre de 2023
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 45515 , F 30, S 8, H M 412278, I/A 58 (26.09.23).

20 de Julio de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: TRIGO MUÑOZ JAIME;BECKER HARALD HEINRICH;TRIGO MUÑOZ JAIME. Apoderado: TRIGOMUÑOZ JAIME. Nombramientos. Apoderado: GARCIA ZARRANZ XABIER;GUIJARRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS JORGEJULIAN;POSADAS MUÑOZ CLARA;MIRA ZARZA GUILLERMO;GARCIA ZARRANZ XABIER;GUIJARRO ESPINOSA DE LOSMONTEROS JORGE JULIAN;POSADAS MUÑOZ CLARA;MIRA ZARZA GUILLERMO;RUIZ ARRIBAS MARIA BEGOÑA;IBAÑEZGABILONDO MANUEL;DOMINGUEZ LAVADORES FERNANDO;GENE LOPEZ MERCE;GUIJARRO ESPINOSA DE LOSMONTEROS JORGE JULIAN;POSADAS MUÑOZ CLARA;MIRA ZARZA GUILLERMO;GARCIA ZARRANZ XABIER. Otrosconceptos: Revocado el poder conferido a favor de don Jaime Trigo Muñoz, en la inscripción 53ª de la hoja social. Datosregistrales. T 38455 , F 10, S 8, H M 412278, I/A 57 (13.07.23).

21 de Junio de 2023
Cambio de domicilio social. PASEO DE RECOLETOS 27, 7ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 38455 , F 10, S 8, H M412278, I/A 56 (14.06.23).

18 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARTOS RAMIREZ JOAQUIN. Datos registrales. T 38455 , F 9, S 8, H M 412278, I/A 55 (11.11.22).

29 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: KAVALIOVA NINA. Datos registrales. T 38455 , F 9, S 8, H M 412278, I/A 54 (22.06.22).

14 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GENE LOPEZ MERCE;GENE LOPEZ MERCE. Datos registrales. T 38455 , F 9, S 8, H M 412278, I/A53 ( 7.03.22).

08 de Febrero de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38455 , F 8, S 8, H M 412278, I/A52 ( 1.02.22).

02 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALVEZ PABLO DANIEL. Vicepresid.: GALVEZ PABLO DANIEL. Consejero: DOMINGUEZLAVADORES FERNANDO. Revocaciones. Apoderado: GALVEZ PABLO DANIEL. Apo.Manc.: GALVEZ PABLO DANIEL.Nombramientos. Consejero: AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL;BLUESEAT TRUST SERVICES SPAIN SL. Apoderado:IBAÑEZ GABILONDO MANUEL;TRIGO MUÑOZ JAIME;DOMINGUEZ LAVADORES FERNANDO. Representan: YOUSFAN MORENORIMA;GARCIA JIMENEZ DANIEL. Datos registrales. T 38455 , F 4, S 8, H M 412278, I/A 51 (25.10.21).

10 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: MULLER KATHRIN;ABESSER OLIVER GEORG HERBERT;ISIGKEIT VOLKER;DINTERCLAUDIA;ZEHMER ANDREAS;SANGER NADJA;PAVLOVIC ZORICA;BECKER HARALD HEINRICH;MAYER MARKUS;MARECKITOBIAS RUDIGER;GALVEZ PABLO DANIEL;IBAÑEZ GABILONDO MANUEL;TRIGO MUÑOZ JAIME;DOMINGUEZ LAVADORESFERNANDO;AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL. Datos registrales. T 38455 , F 2, S 8, H M 412278, I/A 50 ( 3.09.21).

13 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: MEDINA LAGUNA DANIEL. Datos registrales. T 38455 , F 2, S 8, H M 412278, I/A 49 ( 6.05.21).

29 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38455 , F 2, S 8, H M 412278, I/A48 (22.01.21).

28 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: COVARRUBIAS GARZA LUIS MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: CARDONA RICOMARCOS ALEJANDRO. Datos registrales. T 38455 , F 2, S 8, H M 412278, I/A 47 (18.12.20).

19 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ ARANGUEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 38455 , F 2, S 8, H M 412278, I/A 46(12.11.20).

15 de Julio de 2020
Nombramientos. Apoderado: MARTOS RAMIREZ JOAQUIN. Datos registrales. T 38455 , F 1, S 8, H M 412278, I/A 45 ( 8.07.20).

23 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38455 , F 1, S 8, H M 412278, I/A

11 de Febrero de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 38455 , F 1, S 8, H M 412278, I/A43 ( 4.02.19).

10 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: IBAÑEZ GABILONDO MANUEL;GALVEZ PABLO DANIEL;DOMINGUEZ LAVADORESFERNANDO;TRIGO MUÑOZ JAIME;CBRE REAL ESTATE SA;LOPEZ CERON HOYOS SOLEDAD;BOFILL ROVIRA DE VILLARISABEL;CALVO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 32939 , F 225, S 8, H M 412278, I/A 42 (29.11.18).

01 de Marzo de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: COLOM MONFORT ANA;LOPEZ CERON HOYOS SOLEDAD;BOFILL ROVIRA DE VILLAR ISABEL.Apoderado: MANZANO CUESTA CARLOS. Datos registrales. T 32939 , F 225, S 8, H M 412278, I/A 41 (20.02.18).

16 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32939 , F 225, S 8, H M 412278,I/A 40 ( 8.02.18).

27 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: MIRANDA DE PABLO MARIA;GONZALEZ ARANGUEZ FRANCISCO JAVIER;MEDINA LAGUNADANIEL;GONGORA GAY MAITE. Datos registrales. T 32939 , F 223, S 8, H M 412278, I/A 39 (19.12.17).

01 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: MANZANO CUESTA CARLOS. Presidente: MANZANO CUESTA CARLOS. Nombramientos.Presidente: IBAÑEZ GABILONDO MANUEL. Datos registrales. T 32939 , F 223, S 8, H M 412278, I/A 38 (24.07.17).

21 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: CBRE GESTION INMOBILIARIA SL;COLOM MONFORT ANA;LOPEZ CERON HOYOSSOLEDAD;BOFILL ROVIRA DE VILLAR ISABEL;CALVO GARCIA FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: CBRE REAL ESTATESA;COLOM MONFORT ANA;LOPEZ CERON HOYOS SOLEDAD;BOFILL ROVIRA DE VILLAR ISABEL;CALVO GARCIAFERNANDO. Datos registrales. T 32939 , F 222, S 8, H M 412278, I/A 37 (13.12.16).

14 de Diciembre de 2016
Modificaciones estatutarias. 22. Funcionamiento del Consejo de Administración. Datos registrales. T 32939 , F 221, S 8, H M412278, I/A 36 ( 2.12.16).

22 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: MANZANO CUESTA CARLOS;IBAÑEZ GABILONDO MANUEL;GALVEZ PABLODANIEL;DOMINGUEZ LAVADORES FERNANDO. Datos registrales. T 32939 , F 216, S 8, H M 412278, I/A 33 (14.09.16).

Nombramientos. Apoderado: CBRE GESTION INMOBILIARIA SL;COLOM MONFORT ANA;LOPEZ CERON HOYOSSOLEDAD;BOFILL ROVIRA DE VILLAR ISABEL;CALVO GARCIA FERNANDO. Datos registrales. T 32939 , F 219, S 8, H M412278, I/A 34 (14.09.16).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DIAGONAL MAR HOLDCO SL. Datos registrales. T 32939 , F 221,S 8, H M 412278, I/A 35 (14.09.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información