Actos BORME de Dialpack Sociedad Limitada
19 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NU脩EZ GARCIA JUAN MIGUEL. Nombramientos. Adm. Unico: KERALT CHASE SOCIEDADLIMITADA. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21潞.- Duraci贸n del Cargo y retribuci贸n. La duraci贸n del cargo de Administrador煤nico, varios o Consejero, es indefinida. El cargo de miembro del 贸rgano de administraci贸n ser谩 retribuido. La retribuci贸n consistir谩 enuna cantidad fija anual pagadera en dinero. El importe m谩ximo de la remuneraci贸n anual del conjunto de los miembros del 贸rgano deadmin. Otros conceptos: NU脩EZ GARCIA, JUAN MIGUEL, ha sido nombrado representante de la sociedad KERALT CHASESOCIEDAD LIMITADA que a su vez es Administrador Unico de la sociedad DIALPACK SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T962, L 726, F 87, S 8, H AB 13360, I/A 29 (10.05.23).
22 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: NU脩EZ GARCIA JUAN MIGUEL. Presidente: NU脩EZ GARCIA JUAN MIGUEL. Consejero: LOPEZHENARES RAMIRO. Con.Delegado: NU脩EZ GARCIA JUAN MIGUEL. Consejero: ALPUENTE CASTILLEJO MARIA ISABEL.Secretario: ALPUENTE CASTILLEJO MARIA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: NU脩EZ GARCIA JUAN MIGUEL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social.POLIG CAMPOLLANO - CALLE D, NUMERO 52 (ALBACETE). Datos registrales. T 962, L 726, F 87, S 8, H AB 13360, I/A 27(15.05.18).
16 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: TORRALBA ALPUENTE MARIA. Datos registrales. T 947, L 711, F 112, S 8, H AB 13360, I/A 26 (9.12.15).
13 de Octubre de 2014Fe de erratas: DIALPACK SOCIEDAD LIMITADA, rectificado el DNI del apoderado revocado Don Fernando Juan Ruiz Moya, siendoel correcto 6.237.657-B. Datos registrales. T 947, L 711, F 112, S 8, H AB 13360, I/A 24 ( 6.10.14).
Fe de erratas: DIALPACK SOCIEDAD LIMITADA, rectificado el DNI del apoderado nombrado Do帽a Laura Garc铆a Sahuquillo,indicando que el correcto es 47.064.290-B. Datos registrales. T 947, L 711, F 112, S 8, H AB 13360, I/A 25 ( 6.10.14).
18 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ MOYA FERNANDO JUAN. Secretario: RUIZ MOYA FERNANDO JUAN. Nombramientos.Consejero: ALPUENTE CASTILLEJO MARIA ISABEL. Secretario: ALPUENTE CASTILLEJO MARIA ISABEL. Datos registrales. T942, L 706, F 157, S 8, H AB 13360, I/A 20 (11.09.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: RUIZ MOYA FERNANDO JUAN. Datos registrales. T 942, L 706, F 157, S 8, H AB 13360, I/A 21(11.09.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA SAHUQUILLO LAURA. Datos registrales. T 942, L 706, F 157, S 8, H AB 13360, I/A 22(11.09.14).
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 942, L 706, F 157, S 8, H AB 13360, I/A 23 (11.09.14).
08 de Abril de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA AGUILAR ANA MARIA. Datos registrales. T 905, L 669, F 213, S 8, H AB 13360, I/A 18 (1.04.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: TORRALBA ALPUENTE MARIA. Datos registrales. T 905, L 669, F 213, S 8, H AB 13360, I/A 19 (1.04.14).
15 de Abril de 2011Modificaciones estatutarias. ARTICULO 21潞.- El cargo de Administrador ser谩 gratuito. Noobstante el cargo de Consejero Delegadoes retribuido, consistiendo la retribuci贸n en una cantidad mensual fijada por la Junta General para cada ejercicio.. Otros conceptos:MOdificacion de la totalidad de los articulos de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 863, L 627, F 49, S 8, H AB 13360, I/A 17 (6.04.11).
21 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMACHO INIESTA MARIA LUISA. Datos registrales. T 863, L 627, F 49, S 8, H AB 13360, I/A 16(10.02.11).
14 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: LASO MARTINEZ CRISTINA. Secretario: LASO MARTINEZ CRISTINA. Nombramientos.Consejero: RUIZ MOYA FERNANDO JUAN. Secretario: RUIZ MOYA FERNANDO JUAN. Datos registrales. T 863, L 627, F 49, S 8,H AB 13360, I/A 15 ( 4.09.09).