Actos BORME de Diario De Burgos Sa
05 de Noviembre de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 766, L 557, F 198, S 8, H BU 1968, I/A 108 (29.10.21).
07 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 766, L 557, F 198, S 8, H BU 1968, I/A 107 (29.12.20).
15 de Enero de 2020Reelecciones. Adm. Unico: MENDEZ ORDO脩EZ GREGORIO. Datos registrales. T 472, L 263, F 75, S 8, H BU 1968, I/A 106 (9.01.20).
16 de Enero de 2018Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL.Datos registrales. T 472, L 263, F 75, S 8, H BU 1968, I/A 105 (10.01.18).
13 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 472, L 263, F 75, S 8, H BU 1968, I/A 104 (7.06.17).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: SANTAMARINA DURAN JAVIER. Datos registrales. T 472, L 263, F 75, S 8, H BU 1968, I/A 103 (8.03.17).
19 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: LAZARO ORDO脩EZ MERCEDES. Datos registrales. T 472, L 263, F 74, S 8, H BU 1968, I/A 102(13.12.16).
31 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ DE MENCIA VICENTE EDUARDO;MENDEZ POZO GREGORIO;MENDEZ POZO JOSEMANUEL;MENDEZ POZO JUAN CARLOS;MENDEZ ORDO脩EZ MIGUEL;MENDEZ ORDO脩EZ GREGORIO;ALVAREZ MARTINVIDAL VALENTIN;MENDEZ ORDO脩EZ BLANCA. Presidente: RUIZ DE MENCIA VICENTE EDUARDO. Vicepresid.: MENDEZORDO脩EZ MIGUEL. Secretario: GARCIA GALLARDO RIO JUAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: MENDEZ ORDO脩EZGREGORIO. Otros conceptos: Art铆culo de los estatutos: Administraci贸n y Representacion.-Modificaci贸n de art. 15, 28 y 31 de losestatutos:Regulan las formas del administraci贸n. La Administraci贸n podr谩 conferirse a: un administrador 煤nico, dos mancomunados,entre dos y cinco solidarios o a un Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 472, L 263, F 74, S 8, H BU 1968, I/A 100(25.03.15).
Revocaciones. Apo.Sol.: GUTIERREZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 472, L 263, F 74, S 8, H BU 1968, I/A 101(25.03.15).
23 de Febrero de 2015Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 472, L 263, F 73, S 8, H BU 1968, I/A 99(17.02.15).
16 de Febrero de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: LAZARO ORDO脩EZ MERCEDES;LLORENTE HERRERO MARTA. Datos registrales. T 472, L 263, F73, S 8, H BU 1968, I/A 98 (10.02.15).
08 de Enero de 2015Revocaciones. Apoderado: ARNAIZ LOZARES MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 472, L 263, F 73, S 8, H BU 1968, I/A 97(30.12.14).
01 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 472, L 263, F 73, S 8, H BU 1968, I/A 96 (25.11.14).
12 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA ROMERA PEDRO JESUS. Presidente: GARCIA ROMERA PEDRO JESUS.Nombramientos. Presidente: RUIZ DE MENCIA VICENTE EDUARDO. Datos registrales. T 472, L 263, F 72, S 8, H BU 1968, I/A 95( 5.08.14).
04 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: CODON CANO MARIA. Datos registrales. T 472, L 263, F 72, S 8, H BU 1968, I/A 94 (25.06.12).
29 de Diciembre de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 472, L 263, F 72, S 8, H BU 1968, I/A 93 (20.12.11).
09 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: BLANCO NIETO MARINA. Datos registrales. T 472, L 263, F 72, S 8, H BU 1968, I/A 92 (29.11.11).
11 de Marzo de 2011Reelecciones. Secretario: GARCIA GALLARDO RIO JUAN MANUEL. Consejero: GARCIA ROMERA PEDRO JESUS;MENDEZORDO脩EZ MIGUEL;MENDEZ ORDO脩EZ GREGORIO;MENDEZ POZO JUAN CARLOS;MENDEZ POZO JOSE MANUEL. Presidente:GARCIA ROMERA PEDRO JESUS. Vicepresid.: MENDEZ ORDO脩EZ MIGUEL. Consejero: MENDEZ POZO GREGORIO;RUIZ DEMENCIA VICENTE EDUARDO;MENDEZ ORDO脩EZ BLANCA;ALVAREZ MARTIN VIDAL VALENTIN. Datos registrales. T 472, L263, F 71, S 8, H BU 1968, I/A 91 ( 2.03.11).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Apoderado: MENDEZ ORDO脩EZ MIGUEL. Datos registrales. T 472, L 263, F 71, S 8, H BU 1968, I/A 90(26.01.09).
07 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 472, L 263, F 71, S 8, H BU 1968, I/A 89 (23.12.08).