Actos BORME de Digilant Spain Sl
13 de Noviembre de 2019Extinci贸n. Datos registrales. T 42974 , F 159, S 8, H B 404168, I/A 16 ( 5.11.19).
14 de Marzo de 2019Revocaciones. APOD.SOL/MAN: GRA脩A MORAN DAVID. APOD.MANCOMU: ROBERT ARAGONES PEDRO;BONILLA HIGUERAJUAN CAMILO. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GRA脩A MORAN DAVID;BONILLA HIGUERA JUAN CAMILO;JUNYENTRODRIGUEZ PATRICIA;NAZ VILLALBA BELEN;CHARLOTTE BOUCHET;RODES MIRACLE JUAN. Datos registrales. T 42974 , F157, S 8, H B 404168, I/A 15 ( 7.03.19).
23 de Febrero de 2018Revocaciones. APOD.MANCOMU: PRIETO ARES MIGUEL;ROBERT ARAGONES PEDRO;BONILLA HIGUERA JUAN CAMILO.Nombramientos. APOD.SOL/MAN: GRA脩A MORAN DAVID. APOD.MANCOMU: ROBERT ARAGONES PEDRO;BONILLAHIGUERA JUAN CAMILO. Datos registrales. T 42974 , F 156, S 8, H B 404168, I/A 14 (15.02.18).
19 de Diciembre de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: RODES MIRACLE JUAN. Datos registrales. T 42974 , F 155, S 8, H B 404168, I/A 13(11.12.17).
14 de Agosto de 2017Revocaciones. APOD.MANCOMU: PRIETO ARES MIGUEL;ROBERT ARAGONES PEDRO;MARTINEZ DE LUCASRAFAEL;PRIETO ARES MIGUEL;ROBERT ARAGONES PEDRO;MARTINEZ DE LUCAS RAFAEL. Nombramientos.APOD.MANCOMU: PRIETO ARES MIGUEL;ROBERT ARAGONES PEDRO;BONILLA HIGUERA JUAN CAMILO. Datos registrales.T 42974 , F 154, S 8, H B 404168, I/A 12 ( 4.08.17).
24 de Marzo de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 108.000,00 Euros. Datos registrales. T 42974 , F 154, S 8, H B404168, I/A 11 (14.03.17).
14 de Marzo de 2017Cambio de domicilio social. RB DE CATALUNYA Num.123 P.EN (BARCELONA). Datos registrales. T 42974 , F 154, S 8, H B404168, I/A 10 ( 6.03.17).
05 de Agosto de 2015Nombramientos. APOD.MANCOMU: PRIETO ARES MIGUEL;ROBERT ARAGONES PEDRO;MARTINEZ DE LUCAS RAFAEL.Datos registrales. T 42974 , F 152, S 8, H B 404168, I/A 9 (29.07.15).
29 de Junio de 2015Revocaciones. APODERADO: ROBERT ARAGONES PEDRO. Nombramientos. APOD.MANCOMU: PRIETO ARESMIGUEL;ROBERT ARAGONES PEDRO;MARTINEZ DE LUCAS RAFAEL. Datos registrales. T 42974 , F 152, S 8, H B 404168, I/A 8