Actos BORME de Disan Latinoamerica Corporation Sl
29 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: LEON GOMEZ MATEO. Consejero: LEON DUB MARCELO. Presidente: LEON DUB MARCELO.Nombramientos. Presidente: LEON GOMEZ MATEO. Vicepresid.: LEON GOMEZ NICOLAS. Datos registrales. T 36768 , F 81, S 8,H M 515267, I/A 29 (22.11.22).
26 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36768 , F 81, S 8, H M515267, I/A 28 (19.08.22).
28 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DOMINGUEZ ROCIO;FALERO SANCHEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T36768 , F 81, S 8, H M 515267, I/A 27 (21.04.22).
18 de Febrero de 2022Ampliación de capital. Capital: 2.113.782,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.856.160,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 3. Datos registrales. T 36768 , F 80, S 8, H M 515267, I/A 26 (11.02.22).
14 de Enero de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 36768 , F 80, S 8, H M 515267, I/A 25 ( 7.01.22).
21 de Septiembre de 2021Cambio de domicilio social. C/ VILLANUEVA 24 - 1ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 36768 , F 80, S 8, H M 515267, I/A24 (14.09.21).
28 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MORALES JAIRO-ANDRES. Datos registrales. T 36768 , F 79, S 8, H M 515267, I/A 23(21.06.21).
08 de Marzo de 2021Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 36768 , F 79, S 8, H M 515267, I/A 22 ( 1.03.21).
01 de Marzo de 2021Reelecciones. Aud.C.Con.: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36768 , F 79, S 8, H M 515267, I/A 21 (22.02.21).
15 de Febrero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Vicesecret.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. SecreNoConsj:MARTIN SANCHEZ CRISTINA. Revocaciones. Apo.Manc.: LEON DUB MARCELO;LEON GOMEZ MATEO;LEON GOMEZNICOLAS. Apo.Man.Soli: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Apo.Sol.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Nombramientos.
12 de Febrero de 2021Ampliación de capital. Capital: 9.406.055,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.742.378,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 36768 , F 77, S 8, H M 515267, I/A 19 ( 5.02.21).
20 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RIVERA GARCIA DIANA. Revocaciones. Apoderado: ARISMENDI ESPINOSA CRISTHIANARNULFO. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTIN SANCHEZ CRISTINA. Apoderado: PESTAÑA SARTORIUS MARIO;REINAGUTIERREZ JOSE JAVIER;MIRIAM ACEITUNO GUTIERREZ. Cambio de domicilio social. C/ JENNER 6 1º (MADRID). Datosregistrales. T 36768 , F 76, S 8, H M 515267, I/A 18 (13.07.20).
30 de Agosto de 2018Nombramientos. Aud.C.Con.: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 36768 , F 76, S 8, H M 515267, I/A 17(22.08.18).
21 de Agosto de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: CELTA MANAGEMENT INC. Datos registrales. T 36768 , F 76, S 8,H M 515267, I/A 16 (13.08.18).
19 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: CAICEDO MEDINA JUAN FERNANDO;ARISMENDI ESPINOSA CRISTHIAN ARNULFO. Datosregistrales. T 36768 , F 75, S 8, H M 515267, I/A 15 (12.06.18).
26 de Marzo de 2018Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 4ª (MADRID). Datos registrales. T 36768 , F 75, S 8, H M 515267, I/A 14 (19.03.18).
10 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: ESCOBAR SAAVEDRA RICARDO;LEON DUB MARCELO;LEON GOMEZ MATEO;ROZPIDE ORBEGOZOCARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Apo.Manc.: ESCOBAR SAAVEDRA RICARDO;LEON DUB MARCELO;LEON GOMEZMATEO;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Apo.Sol.: ESCOBAR SAAVEDRA RICARDO;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN.Nombramientos. Apo.Manc.: LEON DUB MARCELO;LEON GOMEZ MATEO;LEON GOMEZ NICOLAS. Apo.Man.Soli: ROZPIDEORBEGOZO CARMEN. Apo.Sol.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Datos registrales. T 28614 , F 102, S 8, H M 515267,95 , I/ 13 .(2.01.18).
03 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCOBAR SAAVEDRA RICARDO. Nombramientos. Consejero: MONTES REINA DIANACATALINA. Datos registrales. T 28614 , F 102, S 8, H M 515267,95 , I/ 12 .(22.12.17).
26 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ MARTIN PEDRO ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: RIVERA GARCIADIANA. Datos registrales. T 28614 , F 101, S 8, H M 515267,95 , I/ 11 .(18.07.17).
03 de Agosto de 2015Nombramientos. Vicepresid.: LEON GOMEZ MATEO. Apoderado: VAUGHAN UMAÑA DIANA. Apo.Sol.: ESCOBAR SAAVEDRARICARDO;VAUGHAN UMAÑA DIANA;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. Datos registrales. T 28614 , F 100, S 8, H M 515267,95 , I/9 .(24.07.15).
Nombramientos. Consejero: LEON GOMEZ NICOLAS. Datos registrales. T 28614 , F 101, S 8, H M 515267,95 , I/ 10 .(24.07.15).
06 de Junio de 2013Ampliación de capital. Capital: 369.350,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.336.323,00 Euros. Datos registrales. T 28614 , F 100, S 8,H M 515267,95 , I/ 8 .(30.05.13).
08 de Marzo de 2012Ampliación de capital. Capital: 963.673,00 Euros. Resultante Suscrito: 966.973,00 Euros. Datos registrales. T 28614 , F 99, S 8, HM 515267,95 , I/ 7 .(27.02.12).
31 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: ESCOBAR SAAVEDRA RICARDO;LEON DUB MARCELO;LEON GOMEZ MATEO. Datos registrales. T28614 , F 98, S 8, H M 515267,95 , I/ 4 .(19.01.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T 28614 , F 98, S 8, H M515267,95 , I/ 5 .(19.01.12).
Nombramientos. Apo.Manc.: ESCOBAR SAAVEDRA RICARDO;LEON DUB MARCELO;LEON GOMEZ MATEO;ROZPIDEORBEGOZO CARMEN. Datos registrales. T 28614 , F 99, S 8, H M 515267,95 , I/ 6 .(19.01.12).