Buscador CIF Logo

Actos BORME Discema Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Discema Sa

Actos BORME Discema Sa - A46246559

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Discema Sa con CIF A46246559

🔙 Perfil de Discema Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Discema Sa

12 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Aud.C.Con.: EVIDENCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 131, S 8, H V 21145, I/A 47 (5.09.23).

31 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIA BLASCO ANTONIO FELIX;FERNANDEZ SANCHEZ ALBERTO FRANCISCO.Nombramientos. Consejero: MIRALLES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN;VERASTEGUI SACRISTAN JORGE. Reelecciones.Consejero: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE;DE JAUREGUIZAR SERRANO CARLOS;TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE.Presidente: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Con.Delegado: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Datos registrales. T9854, L 7136, F 131, S 8, H V 21145, I/A 46 (22.05.23).

19 de Enero de 2021
Reelecciones. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 131, S 8, H V 21145, I/A 45 (12.01.21).

04 de Junio de 2020
Nombramientos. Apoderado: OLIVAS MADRIGAL JORGE. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 131, S 8, H V 21145, I/A 44(28.05.20).

11 de Marzo de 2019
Nombramientos. Con.Delegado: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 130, S 8, H V 21145,I/A 43 ( 4.03.19).

13 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Reelecciones. Consejero: TORREGROSA GOZALVEZENRIQUE;SORIA BLASCO ANTONIO FELIX;DE JAUREGUIZAR SERRANO CARLOS;TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE.Presidente: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Consejero: FERNANDEZ SANCHEZ ALBERTO FRANCISCO. Datos registrales.T 9854, L 7136, F 130, S 8, H V 21145, I/A 42 ( 6.08.18).

12 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 130,S 8, H V 21145, I/A 41 ( 5.07.17).

05 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: MIRALLES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 130, S 8, H V21145, I/A 40 (29.05.17).

23 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Aud.C.Con.: EVIDENCE AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Auditor: EVIDENCE AUDITORESSOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 108, S 8, H V 21145, I/A 39 (16.12.14).

30 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 108, S 8, H V 21145, I/A38 (23.07.14).

18 de Junio de 2013
Nombramientos. Con.Delegado: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 108, S 8, H V 21145,I/A 37 (11.06.13).

14 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE;SORIA BLASCO ANTONIO FELIX. Presidente:TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Con.Delegado: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Consejero: DE JAUREGUIZARSERRANO CARLOS;MARTINEZ ACITORES QUINTANA GERARDO;TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE. Nombramientos.Consejero: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE;SORIA BLASCO ANTONIO FELIX;DE JAUREGUIZAR SERRANOCARLOS;TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE. Presidente: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Consejero: FERNANDEZSANCHEZ ALBERTO FRANCISCO. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 107, S 8, H V 21145, I/A 36 ( 7.05.13).

19 de Julio de 2012
Nombramientos. Auditor: EVIDENCE AUDITORES DE CUENTAS SLP. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 107, S 8, H V 21145,I/A 35 (10.07.12).

26 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: SEVILLA CHANZA MARTA. Aud.Supl.: VALERO CANTERO ANGEL LUIS. Datos registrales. T 4259, L1571, F 107, S 8, H V 21145, I/A 34 (17.01.12).

21 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apoderado: TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 107, S 8, H V 21145, I/A33 (12.09.11).

29 de Agosto de 2011
Reelecciones. Aud.C.Con.: SEVILLA CHANZA MARTA. Aud.Supl.C.C: VALERO CANTERO ANGEL LUIS. Datos registrales. T4259, L 1571, F 106, S 8, H V 21145, I/A 32 (18.08.11).

22 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Secretario: MIÑANA ARNAO RAMON GONZALO. Nombramientos. SecreNoConsj: FUERTES ALEGRECONCEPCION. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 106, S 8, H V 21145, I/A 31 (11.02.11).

27 de Enero de 2009
Fe de erratas: Cesados, don Angel Joaquin Navarro Contell como secretario, don Enrique Torregrosa Gozalvez y la mercantil SA ELAGUILA como Miembros del comité ejecutivo de la mercantil DISCEMA SA. Datos registrales. T 4259, L 1571, F 104, S 8, H V21145, I/A 20 (19.09.02).

23 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRES TERNERO ALVAREZ JUAN PEDRO. Nombramientos. Consejero: DE JAUREGUIZARSERRANO CARLOS;MARTINEZ ACITORES QUINTANA GERARDO;TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE. Datos registrales. T4259, L 1571, F 106, S 8, H V 21145, I/A 30 (14.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información