Actos BORME de Disermoda Sa
09 de Junio de 2022Reelecciones. SecreNoConsj: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA REMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA FORDCLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: GOMEZ DEZAMORA FORD CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Presidente:GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Datos registrales. T 23201 , F 222, S 8, H M 77529, I/A 26 ( 2.06.22).
04 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZREMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;FORD PENELOPE ANN;GARCIA MOLINA FRANCISCO.Cons.Del.Sol: REMEDIOS GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;ANN FORDPENELOPE;GARCIA MOLINA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA GOMEZ DE ZAMORA REMEDIOS.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN Y REFUNDEN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 23201 , F 220, S 8, H M 77529, I/A 25 (22.08.17).
19 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Nombramientos. Consejero: GOMEZ DE ZAMORAFORD CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Sol: GOMEZDE ZAMORA FORD CLEMENTE;GOMEZ DE ZAMORA FORD CAROLINA;GARCIA GOMEZ DE ZAMORA MIGUEL ANGEL.Presidente: GOMEZ DE ZAMORA FORD CLEMENTE. Otros conceptos: RATIFICACION EN SU CARGO DE SECRETARIA DELCONSEJO DO脩A REMEDIOS GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ,. Datos registrales. T 23201 , F 219, S 8, H M 77529, I/A 24(11.05.17).
07 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZCLEMENTE;FORD PENELOPE ANN;GARCIA MOLINA FRANCISCO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: REMEDIOS GOMEZ DEZAMORA MARTINEZ;GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE;ANN FORD PENELOPE;GARCIA MOLINA FRANCISCO.Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS.Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Presidente: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Consejero:FORD PENELOPE ANN;GARCIA MOLINA FRANCISCO. Datos registrales. T 23201 , F 219, S 8, H M 77529, I/A 23 (27.02.17).
03 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. C/ ARAGONESES, 10 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 23201 , F 219, S 8, H M 77529, I/A 22(27.01.16).
08 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ BOMBIN ALONSO. Datos registrales. T 23201 , F 218, S 8, H M 77529, I/A 21(26.03.13).
16 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 15 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 23201 , F 218, S 8, H M 77529,I/A 20 ( 4.07.12).
08 de Marzo de 2012Reelecciones. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Secretario: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS.Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ REMEDIOS. Consejero: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Presidente:GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Cons.Del.Sol: GOMEZ DE ZAMORA MARTINEZ CLEMENTE. Consejero: FORDPENELOPE ANN. Cons.Del.Sol: FORD PENELOPE ANN. Consejero: GARCIA MOLINA FRANCISCO. Cons.Del.Sol: GARCIAMOLINA FRANCISCO. Datos registrales. T 23201 , F 217, S 8, H M 77529, I/A 19 (27.02.12).
21 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: HERNANDEZ Y ARRECUBIETA ESTUDIO DE AUDITORIA Y ECO. Datos registrales. T 23201 , F 217, S 8,H M 77529, I/A 18 (10.10.11).
26 de Octubre de 2009Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DISERMODA TRANSPORTE SL. Datos registrales. T 23201 , F 215, S 8, H M77529, I/A 17 (14.10.09).