Buscador CIF Logo

Actos BORME Distribuciones Juan Luna Sociedad Limitada

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Distribuciones Juan Luna Sociedad Limitada

Actos BORME Distribuciones Juan Luna Sociedad Limitada - B46673364

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Distribuciones Juan Luna Sociedad Limitada con CIF B46673364

🔙 Perfil de Distribuciones Juan Luna Sociedad Limitada
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Distribuciones Juan Luna Sociedad Limitada

18 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Auditor: CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T 10999, L 8277, F 186, S 8, H V 279, I/A 44 (11.11.22).

04 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apoderado: GOROSTIZA MANZANO GERARDO. Datos registrales. T 10999, L 8277, F 186, S 8, H V 279, I/A 43(27.07.22).

21 de Febrero de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: AZOR LAFARGA ANA ISABEL. Consejero: LUNA MILLAN ABEL;LUHO INVERSIONESSOCIEDAD LIMITADA;CORREDOR PEREZ TOMAS;MARIATEGUI VALDES ALVARO RAFAEL;GARNICA AROCENA RAMON.Presidente: MARIATEGUI VALDES ALVARO RAFAEL. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL. Otrosconceptos: -- A los efectos del Art. 143 del RRM la persona física designada por GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL para que la

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GRUPO EMPRESARIAL COSTA SL. Datos registrales. T 10999, L8277, F 186, S 8, H V 279, I/A 42 (14.02.22).

01 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10999, L 8277, F 183, S 8, H V279, I/A 40 (24.11.21).

29 de Julio de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANCHEZ DE PABLOS MARIO;GOROSTIZA MANZANO GERARDO. Nombramientos. Apoderado:GOROSTIZA MANZANO GERARDO. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 161, S 8, H V 279, I/A 39 (22.07.21).

15 de Enero de 2021
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 161, S 8, H V

23 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 161, S 8, H V279, I/A 37 (16.09.20).

21 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CORREDOR PEREZ TOMAS;PEREZ BEATO BELLO CELIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:SANCHEZ DE PABLOS MARIO. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 158, S 8, H V 279, I/A 36 (14.02.20).

19 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ BEATO BELLO CELIA;CARBO FERNANDEZ CARLOS. Presidente: CARBO FERNANDEZCARLOS. Nombramientos. Consejero: MARIATEGUI VALDES ALVARO RAFAEL;GARNICA AROCENA RAMON. Presidente:MARIATEGUI VALDES ALVARO RAFAEL. Otros conceptos: Se ratifica el nombramiento de Doña Ana Isabel Azor Lafarga comosecretaria no consejera del consejo. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 157, S 8, H V 279, I/A 35 (12.02.20).

22 de Octubre de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICADA LA REDACCIN DEL ARTICULO 20º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y PORCONSIGUIENTE MODIFICADO EL SISTEMA DE RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. . Datos registrales. T10421, L 7702, F 157, S 8, H V 279, I/A 34 (15.10.19).

11 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ BARQUERO COVADONGA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOROSTIZA MANZANOGERARDO. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 154, S 8, H V 279, I/A 33 ( 4.03.19).

15 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Sol.: LUNA MILLAN JUAN ELIAS. Apo.Man.Soli: LUNA MILLAN JUAN ELIAS;LUNA MILLAN ABEL;LUNAMILLAN JUAN ELIAS;LUNA MILLAN ABEL. Datos registrales. T 10421, L 7702, F 154, S 8, H V 279, I/A 32 ( 8.06.18).

28 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MATAIX MOLTO LUIS. Apoderado: MATAIX MOLTO LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli:GONZALEZ BARQUERO COVADONGA. Datos registrales. T 10119, L 7401, F 135, S 8, H V 279, I/A 31 (21.02.18).

06 de Abril de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CORREDOR PEREZ TOMAS. Datos registrales. T 10119, L 7401, F 133, S 8, H V 279, I/A 30(30.03.17).

14 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: MATAIX MOLTO LUIS. Datos registrales. T 10119, L 7401, F 132, S 8, H V 279, I/A 29 ( 7.03.17).

23 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10119, L 7401, F 132, S 8, H V279, I/A 28 (16.01.17).

02 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARNICA AROCENA RAMON. Nombramientos. Consejero: CORREDOR PEREZ TOMAS. Datosregistrales. T 10119, L 7401, F 132, S 8, H V 279, I/A 27 (26.08.16).

26 de Julio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUNA MILLAN ABEL;LUNA MILLAN JUAN ELIAS;MATAIX MOLTO LUIS. Datos registrales. T10119, L 7401, F 129, S 8, H V 279, I/A 26 (18.07.16).

08 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LUNA MILLAN ABEL;LUHO INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero:PEREZ BEATO BELLO CELIA;CARBO FERNANDEZ CARLOS;GARNICA AROCENA RAMON;LUNA MILLAN ABEL;LUHO

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUNA MILLAN ABEL;LUNA MILLAN JUAN ELIAS;PEREZ BEATO BELLO CELIA. Datosregistrales. T 10119, L 7401, F 127, S 8, H V 279, I/A 25 (31.05.16).

22 de Abril de 2016
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GLOBAL GAZEL SL. Datos registrales. T 2700, L 18, F 104, S 8, HV 279, I/A 23 (15.04.16).

09 de Febrero de 2016
Nombramientos. Auditor: PROVALENCIA CONSULTORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA. Datos registrales. T 2700, L 18, F104, S 8, H V 279, I/A 22 ( 2.02.16).

10 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: PROVALENCIA CONSULTORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA. Datos registrales. T 2700, L 18, F104, S 8, H V 279, I/A 21 ( 3.10.13).

25 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LUNA VALLEJO JUAN. Datos registrales. T 2700, L 18, F 103, S 8, H V 279, I/A 19 (16.11.11).

Ampliación de capital. Capital: 300.001,17 Euros. Resultante Suscrito: 366.111,17 Euros. Datos registrales. T 2700, L 18, F 103, S8, H V 279, I/A 20 (16.11.11).

13 de Junio de 2011
Cambio de domicilio social. C/ BELGICA 19 - POLIGONO INDUSTRIAL ELS OLIVARONS (SOLLANA). Datos registrales. T 2700,L 18, F 103, S 8, H V 279, I/A 18 ( 2.06.11).

26 de Abril de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: MILLAN PEREZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 2700, L 18, F 103, S 8, H V 279, I/A 17(13.04.11).

08 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: PROAUDIT VALENCIA SLP. Datos registrales. T 2700, L 18, F 103, S 8, H V 279, I/A 16 (28.01.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información