Buscador CIF Logo

Actos BORME Distribuidora Almeriense De Publicaciones Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Distribuidora Almeriense De Publicaciones Sl

Actos BORME Distribuidora Almeriense De Publicaciones Sl - B04177739

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Almeria para Distribuidora Almeriense De Publicaciones Sl con CIF B04177739

🔙 Perfil de Distribuidora Almeriense De Publicaciones Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Almeria

Actos BORME de Distribuidora Almeriense De Publicaciones Sl

19 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ DIAZ JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ ESTEBAN ALFONSO. Datosregistrales. T 1735 , F 135, S 8, H AL 3110, I/A 55 ( 6.06.23).

04 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO;LOPEZ DIAZ JESUS;BRAVO SILVA MARTA. Datosregistrales. T 1735 , F 134, S 8, H AL 3110, I/A 55 (23.03.23).

07 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ DIAZ JESUS;BRAVO SILVA MARTA;PASAMAR LORENZO LIDIA;ORTEGO MAGANO LUIS.Datos registrales. T 1735 , F 134, S 8, H AL 3110, I/A 53 (22.02.23).

Nombramientos. Apo.Sol.: SANTOS MARTIN ERNESTO. Datos registrales. T 1735 , F 134, S 8, H AL 3110, I/A 54 (22.02.23).

27 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA VALENCIA BELEN. Apo.Man.Soli: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO. Apoderado: SANFRUTOSFERNANDEZ LUIS DOMINGO. Datos registrales. T 1735 , F 133, S 8, H AL 3110, I/A 52 (19.12.22).

26 de Julio de 2021
Reelecciones. Adm. Unico: DISTRIMEDIOS SL. Datos registrales. T 1735 , F 133, S 8, H AL 3110, I/A 51 (16.07.21).

02 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1735 , F 133, S 8, H AL 3110, I/A 50 (19.02.21).

16 de Noviembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SERRANO BUSTAMANTE JORGE;CABALLERO JULIA FERNANDO. Apo.Sol.: MORENO ORTEGAPEDRO. Apo.Manc.: DEL POZO HERNANZ JUAN MANUEL;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli:BRAVO SILVA MARTA. Datos registrales. T 1735 , F 132, S 8, H AL 3110, I/A 49 ( 4.11.20).

20 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1735 , F 131, S 8, H AL 3110, I/A 48 ( 9.01.20).

29 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABALLERO JULIA FERNANDO;GARCIA DE JUAN CARMEN;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRANO BUSTAMANTE JORGE;LOPEZ DIAZ JESUS;VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO;CABALLERO JULIA FERNANDO. Datos registrales. T 1735 , F 130, S 8, H AL 3110, I/A 46(17.05.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO ORTEGA PEDRO;GARCIA DE JUAN CARMEN. Datos registrales. T 1735 , F 131, S 8, H AL3110, I/A 47 (17.05.19).

22 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER;GARCIA DE JUAN CARMEN;SERRANO GONZALEZ MARIA DELCARMEN;ORTEGA MARTINEZ ANDRES. Nombramientos. Apo.Sol.: BRAVO SILVA MARTA;GARCIA VALENCIA BELEN;REINAVALENCIA ROBERTO. Datos registrales. T 1735 , F 129, S 8, H AL 3110, I/A 44 ( 5.04.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA DE JUAN MARIA DEL CARMEN;SERRANO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN. Datosregistrales. T 1735 , F 129, S 8, H AL 3110, I/A 45 ( 5.04.19).

11 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1735 , F 129, S 8, H AL 3110, I/A 43 (29.11.18).

25 de Junio de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: DEL POZO HERNANZ JUAN MANUEL;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Nombramientos. Apo.Manc.:DEL POZO HERNANZ JUAN MANUEL;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL. Datos registrales. T 1735 , F 128, S 8, H AL 3110, I/A 42(18.06.18).

30 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1735 , F 128, S 8, H AL 3110, I/A 41 (20.11.17).

05 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1735 , F 128, S 8, H AL 3110, I/A 40 (28.12.16).

29 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: DISTRIMEDIOS SL;FERNANDEZ AGUILAR JUAN. Con.Delegado: DISTRIMEDIOS SL. Presidente:DISTRIMEDIOS SL. SecreNoConsj: ORTEGO MAGANO LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: DISTRIMEDIOS SL. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 1735 , F128, S 8, H AL 3110, I/A 39 (21.09.16).

29 de Junio de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABALLERO JULIA FERNANDO;GARCIA DE JUAN CARMEN;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO.Datos registrales. T 1735 , F 127, S 8, H AL 3110, I/A 37 (16.06.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: FIZ GARCIA MARIA TERESA;GONZALEZ RAMIREZ MARIA CARMEN;ZARZUELA MONTESANTONIO;ORTEGA ORTEGA JUANA JOSEFA;FIZ GARCIA MARIA TERESA. Apo.Man.Soli: SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;GARCIA DE JUAN CARMEN;NUÑEZ GARCIA JUAN MIGUEL;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 1735 ,F 127, S 8, H AL 3110, I/A 38 (16.06.16).

27 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA MARTINEZ ANDRES;MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER;SERRANO GONZALEZ MARIA DELCARMEN;GARCIA DE JUAN CARMEN. Datos registrales. T 665 , F 178, S 8, H AL 3110, I/A 36 (16.10.15).

18 de Agosto de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: RED DE DISTRIBUCIONES EDITORIALES. Secretario: CABRERA CASTRO JAVIER.Nombramientos. Consejero: DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA SL. SecreNoConsj: ORTEGO MAGANO LUIS. Datosregistrales. T 665 , F 178, S 8, H AL 3110, I/A 35 ( 7.08.15).

13 de Octubre de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: DEL POZO HERNANZ JUAN MANUEL;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 665 , F177, S 8, H AL 3110, I/A 34 ( 2.10.14).

23 de Julio de 2014
Revocaciones. Apo.Manc.: JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Apoderado: SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL. Apo.Manc.: SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;SERRANO GONZALEZCASTO-MANUEL;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;GARCIA DE JUAN MARIA DEL CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: NUÑEZ GARCIA JUAN MIGUEL;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;GARCIA DE JUAN CARMEN;IRIONDOARRIOLA ALBERTO. Datos registrales. T 665 , F 176, S 8, H AL 3110, I/A 33 (15.07.14).

22 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Presidente:JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos.Con.Delegado: DISTRIMEDIOS SL. Consejero: DISTRIMEDIOS SL;RED DE DISTRIBUCIONES EDITORIALES. Presidente:DISTRIMEDIOS SL. Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ AGUILAR JUAN. Otros conceptos: También se acordó la prohibiciónde competencia establecida en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, autorizándose expresamente para que puedandedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de estasociedad. Datos registrales. T 665 , F 176, S 8, H AL 3110, I/A 32 (11.07.14).

29 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 665 , F 176, S 8, H AL 3110, I/A 31 (20.01.14).

30 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: SANFRUTOS FERNANDEZ LUIS;FIZ GARCIA MARIA TERESA;GONZALEZ RAMIREZ MARIACARMEN. Datos registrales. T 665 , F 176, S 8, H AL 3110, I/A 30 (23.10.13).

08 de Agosto de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: FIZ GARCIA MARIA TERESA;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;GARCIA DE JUAN MARIADEL CARMEN. Datos registrales. T 665 , F 175, S 8, H AL 3110, I/A 29 (31.07.13).

22 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 665 , F 175, S 8, H AL 3110, I/A 28 (14.01.13).

22 de Agosto de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZAGUILAR JUAN. Reelecciones. Consejero: JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL.Presidente: JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 665 , F 175, S 8, H AL 3110, I/A 27 ( 8.08.11).

14 de Julio de 2011
Nombramientos. Apo.Manc.: SANFRUTOS FERNANDEZ LUIS;ORTEGA ORTEGA JUANA JOSEFA;FIZ GARCIA MARIATERESA;SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL;GONZALEZ RAMIREZ MARIA CARMEN. Otros conceptos: Revocación depoder NO INSCRITO, otorgado el 17-07- 2.002,por notario SR Javier Manrique Plaza, n&3400 a favor de DONLUIS SANFRUTOSFERNANDEZ, DOÑA ANA TERESA ALCALDE GONZALEZ,DOÑA MARIA TERESA FIZ GARCIA, DON CASTO-MANUEL SERRANOGONZALEZ Y DOÑA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RAMIREZ. Datos registrales. T 665 , F 174, S 8, H AL 3110, I/A 25(30.06.11).

Nombramientos. Apoderado: SERRANO GONZALEZ CASTO-MANUEL. Datos registrales. T 665 , F 175, S 8, H AL 3110, I/A 26 (1.07.11).

27 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 665 , F 174, S 8, H AL 3110, I/A 24 (14.01.10).

17 de Julio de 2009
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.- El transporte de mercancias por carretera, almacenamiento, cargay descarga, distribución de mercancias transitorías, agencia de transporte y comercio al por mayor de mercancias.. Ampliacion delobjeto social. El transporte de mercancias por carretera, almacenamiento, carga y descarga, distribución de mercancias transitorías,agencia de transporte y comercio al por mayor de mercancias. Datos registrales. T 665 , F 174, S 8, H AL 3110, I/A 23 ( 8.07.09).

20 de Abril de 2009
Nombramientos. Apo.Manc.: ZARZUELA MONTES ANTONIO;JULBES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 665, F 173, S 8, H AL 3110, I/A 22 ( 7.04.09).

29 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 665 , F 173, S 8, H AL 3110, I/A 21 (19.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información