Actos BORME de Distribuidora Farmaceutica Leridana Sa
05 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: COFARES CORPORACION SL. Presidente: COFARES CORPORACION SL. Consejero:COFARES CORPORACION SL;MARCELLES RAMIREZ JOSE LUIS;PEREZ SEGADO MARTIN;LEWIN DE OROZCO LOURDESLUZ. Secretario: MARCELLES RAMIREZ JOSE LUIS. Socio 煤nico: COFARES CORPORACION SL. Auditor: DELOITTE SL.Revocaciones. Apo.Sol.: VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER;SANZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: MUELAS GARCIA-ESTELLER SOLEDAD;GONZALEZ BOSCH CARLOS;LINARES BERTOLIN GASPAR;GUENECHEA SALAZAR JUANIGNACIO;PASTOR FERNANDEZ EDUARDO;PEREZ SEGADO MARTIN;SANZ OTERO JOSE LUIS;ALISES NARANJO MIGUELANGEL;LEWIN DE OROZCO LOURDES LUZ;GOMEZ BLANCO JESUS ANGEL. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 45 (28.12.17).
13 de Diciembre de 2017Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL de la Hoja correspondiente a la Sociedad por el plazo de seis meses, de conformidad conel art铆culo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, como consecuencia de la fusi贸n por absorci贸n de la misma por la entidadCOFARES CATALU脩A Y ARAGON SAU, como Sociedad absorbente. Datos registrales. T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A44 no (5.12.17).
17 de Mayo de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: COFARES CORPORACION SL. Datos registrales. T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A43 ( 8.05.17).
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: PEREZ DELGADO JUAN JOSE. Consejero: PEREZ DELGADO JUAN JOSE. Revocaciones.Apoderado: PEREZ DELGADO JUAN JOSE. Datos registrales. T 886 , F 212, S 8, H L 1634, I/A 44 ( 8.05.17).
05 de Abril de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.752.880,50 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:91.610,00 Euros. Desembolsado: 91.610,00 Euros. Resultante Suscrito: 91.610,00 Euros. Resultante Desembolsado: 91.610,00 Euros.Datos registrales. T 886 , F 187, S 8, H L 1634, I/A 42 (28.03.17).
20 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ BOSCH CARLOS;GUENECHEA SALAZAR JUAN IGNACIO;LINARES BERTOLINGASPAR;MUELAS GARCIA-ESTELLER SOLEDAD;PASTOR FERNANDEZ EDUARDO;PEREZ SEGADO MARTIN;SANZ OTEROJOSE LUIS;ALISES NARANJO MIGUEL ANGEL;LEWIN DE OROZCO LOURDES LUZ;GOMEZ BLANCO JESUS ANGEL. Apo.Sol.:VICENTE PEREZ ANGEL JAVIER;SANZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 886 , F 133, S 8, H L 1634, I/A 41(12.12.16).
16 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 886 , F 132, S 8, H L 1634, I/A 40 ( 9.11.15).
30 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: COFARES CORPORACION SL. Secretario: COFARES CATALU脩A Y ARAGON SA. Consejero:COFARES CORPORACION SL;COFARES CATALU脩A Y ARAGON SA;COMERCIAL ANONIMA VICENTE FERRER SA.Nombramientos. Consejero: COFARES CORPORACION SL;MARCELLES RAMIREZ JOSE LUIS;PEREZ DELGADO JUANJOSE;PEREZ SEGADO MARTIN;LEWIN DE OROZCO LOURDES LUZ. Presidente: COFARES CORPORACION SL. Secretario:MARCELLES RAMIREZ JOSE LUIS. Cons.Del.Man: COFARES CORPORACION SL;PEREZ DELGADO JUAN JOSE.Modificaciones estatutarias. Domicilio.-. Capital.-. Administraci贸n y Representacion.-. Funcionamiento Junta Gral.-. FuncionamientoJunta Gral.-. Funcionamiento Junta Gral.-. Funcionamiento Junta Gral.-. Administraci贸n y Representacion.-. Administraci贸n yRepresentacion.-. Administraci贸n y Representacion.-. Administraci贸n y Representacion.-. Administraci贸n y Representacion.-. Otros.-.Otros.-. Otros conceptos: Se modifican los art铆culos 3潞, 6潞, 12潞, 14潞, 15潞, 18潞, 19潞, 21潞 a 23潞, 25潞, 26潞, 29潞 y 32潞 de los estatutossociales, y quedan sin contenido los art铆culos 24潞 y 27潞.- Datos registrales. T 886 , F 68, S 8, H L 1634, I/A 39 (23.09.15).
17 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: MELE ALSINA PEDRO. Con.Delegado: MELE ALSINA PEDRO. Secretario: BARRULL BECERRANURIA. Consejero: MELE ALSINA PEDRO;BARRULL BECERRA NURIA;PEREZ DELGADO JUAN JOSE. Nombramientos.
22 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: SARRAMIA RONCERO MIGUEL ANGEL;ALDAVO PINEDA MARIA ROSA;HELLIN PARELLADAALFREDO;FREIXENET FONDEVILA JOAN. Nombramientos. Consejero: COFARES CORPORACION SL;COFARES CATALU脩A YARAGON SA;COMERCIAL ANONIMA VICENTE FERRER SA. Otros conceptos: Fijar en 6 el n煤mero de miembros del Consejo deAdministraci贸n. Datos registrales. T 886 , F 66, S 8, H L 1634, I/A 37 (14.07.14).
04 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO PORTOS MIGUEL;PURGIMON DIAZ JOAN;TORRES SOLE ENRIQUETA. Modificacionesestatutarias. Se modifica el art铆culo 8潞 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 886 , F 65, S 8, H L 1634, I/A 36 (28.03.14).
14 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ADIELL AUDITORS SLP. Datos registrales. T 884 , F 132, S 8, H L 1634, I/A 34 ( 5.08.13).
12 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: PALAU MORE JOSE MARIA;ALBAREDA MAYMO MARIA ALBA. Modificaciones estatutarias. 8.Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 884 , F 132, S 8, H L 1634, I/A 35 ( 5.08.13).
26 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 585.013,40 Euros. Desembolsado: 585.013,40 Euros. Resultante Suscrito: 2.752.880,50 Euros.Resultante Desembolsado: 2.752.880,50 Euros. Otros conceptos: Delegaci贸n en los Administradores de la facultad de acordarenuna o varias veces el aumento de capital social. Datos registrales. T 884 , F 54, S 8, H L 1634, I/A 33 (17.08.11).
17 de Agosto de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ DELGADO JUAN JOSE;SANZ MARQUEZ PEDRO. Nombramientos. Apoderado: PEREZDELGADO JUAN JOSE. Datos registrales. T 884 , F 53, S 8, H L 1634, I/A 32 ( 5.08.11).
11 de Enero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 704.672,50 Euros. Desembolsado: 704.672,50 Euros. Resultante Suscrito: 2.167.867,10 Euros.Resultante Desembolsado: 2.167.867,10 Euros. Otros conceptos: Que en la Junta General de 22 de mayo de 2009, se acord贸ladelegaci贸n en los administradores la facultad de acordar enuna o varias veces el aumento de capital social que consta en la presenteinscripci贸n. Datos registrales. T 884 , F 44, S 8, H L 1634, I/A 31 (28.12.09).
18 de Noviembre de 2009Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DISFARCA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA SL. Datos registrales. T 882 , F 94,S 8, H L 1634, I/A 30 ( 5.11.09).
11 de Septiembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 53.849,60 Euros. Desembolsado: 53.849,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.463.194,60 Euros.Resultante Desembolsado: 1.463.194,60 Euros. Datos registrales. T 882 , F 92, S 8, H L 1634, I/A 29 ( 2.09.09).
26 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PURGIMON DIAZ JOAN;FREIXINET FONDEVILA JUAN;SARRAMIA RONCERO MIGUELANGEL;ALBAREDA MAYMO MARIA ALBA;MELE ALSINA PEDRO. Con.Delegado: MELE ALSINA PEDRO. Consejero: PALAU MOREJOSE MARIA;CASTRO PORTOS MIGUEL;TORRES SOLER ENRIQUETA;ALDAVO PINEDA MARIA ROSA;HELLIN PARELLADAALFREDO;SANZ MARQUEZ PEDRO. Presidente: MELE ALSINA PEDRO. Secretario: SARRAMIA RONCERO MIGUEL ANGEL.Revocaciones. Apo.Sol.: SARRAMIA RONCERO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: SARRAMIA RONCERO MIGUELANGEL;MELE ALSINA PEDRO;ALBAREDA MAYMO MARIA ALBA;PALAU MORE JOSE MARIA;CASTRO PORTOSMIGUEL;TORRES SOLE ENRIQUETA;ALDAVO PINEDA MARIA ROSA;HELLIN PARELLADA ALFREDO;PURGIMON DIAZJOAN;FREIXENET FONDEVILA JOAN;PEREZ DELGADO JUAN JOSE;BARRULL BECERRA NURIA. Presidente: MELE ALSINAPEDRO. Secretario: BARRULL BECERRA NURIA. Con.Delegado: MELE ALSINA PEDRO. Modificaciones estatutarias. Semodifica el art铆culo 23潞 relativo a la duraci贸n de cargos, que de ahora en adelante ser谩 de seis a帽os.. Otros conceptos: Ratificadoslos poderes conferidos a don Pedro Sanz M谩rquezy don Juan-Jos茅 P茅rez Delgado, en escritura autorizada por don Francisco JavierHern谩iz Corrales, el d铆a 18 de junio de2004, y que caus贸 la inscripci贸n 22潞 en el historial de la Sociedad.Se acuerda aumentar eln煤mero de Consejeros, pasando de once a doce. Datos registrales. T 882 , F 91, S 8, H L 1634, I/A 28 (16.06.09).
08 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 210.350,00 Euros. Desembolsado: 210.350,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.409.345,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.409.345,00 Euros. Datos registrales. T 880 , F 16, S 8, H L 1634, I/A 27 (30.03.09).
13 de Enero de 2009Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA LERIDANA SA. Datos registrales. T 880 , F14, S 8, H L 1634, I/A 26 (31.12.08).