Actos BORME de Distribuidora Regional Del Gas Sa
10 de Abril de 2015Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 1451 , F 161, S 8, H VA 4251, I/A 73 ( 1.04.15).
17 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apoderado: FOLGADO DELGADO DAVID. Datos registrales. T 1451 , F 161, S 8, H VA 4251, I/A 72 (10.11.14).
11 de Noviembre de 2014Revocaciones. Apoderado: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Apo.Man.Soli: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Datos registrales. T 1451 , F161, S 8, H VA 4251, I/A 71 ( 3.11.14).
10 de Julio de 2014Nombramientos. Apoderado: SOMOZA VILLAR ANA-STEFANIA;LOSADA RAMIREZ JOSE-CARLOS. Datos registrales. T 1451 , F159, S 8, H VA 4251, I/A 70 ( 3.07.14).
14 de Mayo de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: DOMENECH PIERA JAVIER. Datos registrales. T 1451 , F 159, S 8, H VA 4251, I/A 69 ( 7.05.14).
28 de Abril de 2014Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1451 , F 159, S 8, H VA 4251, I/A 68 (21.04.14).
27 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PEREÑA PINEDO IGNACIO. Consejero: CAMU PHILIPPE LOUIS HUBERT;LYNEHAM PETERROBERT;BOTTO POALA MATTEO;AGUIRRE PEMAN CLAUDIO;BERGASA CACERES FERNANDO. Con.Delegado: BERGASACACERES FERNANDO. Presidente: BERGASA CACERES FERNANDO. Nombramientos. Adm. Unico: BERGASA CACERESFERNANDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único."Artículo 13º (bis).- Asistencia telemática a las Juntas Generalesº=. Los accionistas con derecho de asistencia a la reunión de la JuntaGeneral que se celebrará en el lugar indicado en la convocatoria podrán ejercer ese derecho utilizando medios electrónicos otelemáticos de comuniciación a "Artículo 16º (bis).- Administradores de la Sociedad. óNombramientoº. Para ser designadoAdministrador no se precisará ser accionista. óDuración del cargoº. El Administrador único o los Administradores mancomunadosnombrados desempeñarán su cargo por un plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de su "Artículo 17º.- Composición del Consejo deAdministración. La Sociedad se podrá regir y administrar, con las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las quecompeten a la Junta General con arreglo a la Ley y a estos Estatutos, por un Consejo de Administración, que estará compuesto por"Articulo 20º.- Designación de caraos en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración nombrara de su seno alPresidente. El Presidente tendrá, entre otras, las siguientes funciones: a) Convocará las reuniones del Consejo de Administración -sinperjuicio de lo indicado en el artículo. Datos registrales. T 1451 , F 157, S 8, H VA 4251, I/A 66 (20.02.14).
Nombramientos. Apoderado: PEREÑA PINEDO IGNACIO. Datos registrales. T 1451 , F 159, S 8, H VA 4251, I/A 67 (20.02.14).
04 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: POLO BAÑOS BORJA;GARCIA MENENDEZ JUAN MANUEL;BARREIRO HERNANDEZMERCEDES;SANCHEZ MUSLERA DIEGO;CRESPO MILLAN FRANCISCO JAVIER;CAMPILLO FERNANDEZ JULIO CESAR. Datosregistrales. T 1418 , F 156, S 8, H VA 4251, I/A 64 (28.01.14).
Revocaciones. Apoderado: DE HOCES DE IÑIGUEZ LOPE JUAN. Apo.Man.Soli: ROYO PUEYO JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 1451 , F 157, S 8, H VA 4251, I/A 65 (28.01.14).
16 de Enero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIN LOPEZ-OTERO JOSE LUIS. Presidente: MARIN LOPEZ-OTERO JOSE LUIS.Nombramientos. Presidente: BERGASA CACERES FERNANDO. Datos registrales. T 1418 , F 155, S 8, H VA 4251, I/A 63 (9.01.14).
06 de Agosto de 2013Nombramientos. Apoderado: AVILA GARCIA CRISTINA;FOLGADO DELGADO DAVID;PEREÑA PINEDO IGNACIO;MONTANERGUTIERREZ IGNACIO;OLIVAN CONTRERAS LUIS;BENITEZ GONZALEZ FERNANDO;CASAUS LOPEZ CARLOS Datosregistrales. T 1418 , F 153, S 8, H VA 4251, I/A 62 (30.07.13).
19 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1418 , F 153, S 8, H VA 4251, I/A 61 (12.07.13).
09 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Nombramientos. SecreNoConsj: PEREÑA PINEDO IGNACIO.Datos registrales. T 1418 , F 152, S 8, H VA 4251, I/A 59 (30.04.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: PINILLA ZAPATA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1418 , F 153, S 8, H VA 4251, I/A 60 (30.04.13).
12 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: DE HOCES DE IÑIGUEZ LOPE JUAN. Datos registrales. T 1418 , F 152, S 8, H VA 4251, I/A 58 (5.02.13).
06 de Febrero de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1418 , F 152, S 8, H VA 4251, I/A 57 (30.01.13).
20 de Julio de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ FERNANDEZ MONICA. Apo.Man.Soli: PACHECO PLAZA TERESA. Apoderado: CORTINAGONZALEZ FERNANDO;DOMENECH PIERA JAVIER;RAMON TEIJELO PIO JAVIER;ROYO PUEYO JOSE ANTONIO;CRESPOMILLAN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DOMENECH PIERA JAVIER;RAMON TEIJELO PIO JAVIER;ROYOPUEYO JOSE ANTONIO;CRESPO MILLAN FRANCISCO JAVIER;FAUQUIE BORRAJO DAVID;POLO BAÑOS BORJA. Apo.Sol.:ANDRES ALONSO JESUS ALBERTO;ARES MARTIN JOSE MARIANO;MARTIN SAN PEDRO ANTONIO;PESQUERA RODRIGUEZCARLOS;GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN OLIVA;SANTOS GALAN CESAR;GALLEGO GARCIA DAVID;JIMENEZ GONZALEZJORGE;GONZALEZ DE JUAN JOSE MARIA;MARTINEZ GARCIA JUAN CARLOS;MUÑOZ DIAZ JUAN LUIS;SEIJAS BARTULOSLAURA;GONZALEZ FERNANDEZ MONICA;GARCIA ALONSO PALOMA;LORENZO LASTRAS MARIA DEL PILAR;PRIETO GAYRAQUEL;SANTOS GALAN SONIA;ARRIBAS SANCHEZ VALERICO;PINILLA ZAPATA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 1406 , F54, S 8, H VA 4251, I/A 56 (11.07.12).
09 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: AVILA GARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 1406 , F 52, S 8, H VA 4251, I/A 55 (25.11.11).
25 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ-PINTADO LOPEZ OLAF. Nombramientos. Consejero: BERGASA CACERES FERNANDO.Con.Delegado: BERGASA CACERES FERNANDO. Apoderado: FAUQUIE BORRAJO DAVID. Datos registrales. T 1390 , F 58, S 8,H VA 4251, I/A 54 (14.10.11).
23 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MANCHADO CALDERON VICTORIANO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: FAUQUIEBORRAJO DAVID. Datos registrales. T 1390 , F 58, S 8, H VA 4251, I/A 53 (11.08.11).
11 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: CRESPO MILLAN FRANCISCO JAVIER;ARES MARTIN JOSE MARIANO;ANDRES ALONSO JESUSALBERTO. Apoderado: CORTINA GONZALEZ FERNANDO;DOMENECH PIERA JAVIER;RAMON TEIJELO PIO JAVIER;PINILLAZAPATA JUAN CARLOS;ROYO PUEYO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: CORTINA GONZALEZFERNANDO;DOMENECH PIERA JAVIER;RAMON TEIJELO PIO JAVIER;ROYO PUEYO JOSE ANTONIO;CRESPO MILLANFRANCISCO JAVIER;ANDRES ALONSO JESUS ALBERTO;ARES MARTIN JOSE MARIANO. Datos registrales. T 1390 , F 55, S 8,H VA 4251, I/A 51 ( 2.05.11).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GUINDIN FERMIN;GARCIA VICENTE SILVIA. Datos registrales. T 1390 , F 57, S 8, HVA 4251, I/A 52 ( 2.05.11).
10 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: FERNANDEZ DIAZ JIMENA. Consejero: RAMON TEIJELO PIO JAVIER;ENDESA GAS SA.Presidente: RAMON TEIJELO PIO JAVIER. Consejero: CRESPO MILLAN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj:MANCHADO CALDERON VICTORIANO JOSE. Consejero: CAMU PHILIPPE LOUIS HUBERT;LYNEHAM PETER ROBERT;BOTTOPOALA MATTEO;DIAZ-PINTADO LOPEZ OLAF;AGUIRRE PEMAN CLAUDIO;MARIN LOPEZ-OTERO JOSE LUIS. Presidente:MARIN LOPEZ-OTERO JOSE LUIS. Otros conceptos: Modificación integral de los Estatutos de la Sociedad. Datos registrales. T995 , F 70, S 8, H VA 4251, I/A 49 (31.01.11).
Nombramientos. Apoderado: CORTINA GONZALEZ FERNANDO;DOMENECH PIERA JAVIER;RAMON TEIJELO PIOJAVIER;PINILLA ZAPATA JUAN CARLOS;ROYO PUEYO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 995 , F 72, S 8, H VA 4251, I/A 50(31.01.11).
Otros conceptos: Conforme al Art. 122,3 RRM se hace constar la circunstanciade haberse emitido y entregado al titular del títulomúltiple nominativo representativo de las acciones de la Sociedad. Datos registrales. T 1390 , F 55, S 8, H VA 4251, I/A 50 N(31.01.11).
07 de Febrero de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: NUBIA 2000 SL. Datos registrales. T 995 , F 70, S 8, H VA 4251,I/A 48 (26.01.11).
23 de Septiembre de 2010Declaración de unipersonalidad. Socio único: ENDESA GAS SA. Datos registrales. T 995 , F 69, S 8, H VA 4251, I/A 47(14.09.10).
25 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: LLORENTE MUÑOZ PATRICIO. Consejero: LLORENTE MUÑOZ PATRICIO;LLORENTE MUÑOZALEJANDRO. Nombramientos. Presidente: RAMON TEIJELO PIO JAVIER. Consejero: CRESPO MILLAN FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 995 , F 69, S 8, H VA 4251, I/A 46 (16.08.10).
28 de Enero de 2010Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 995 , F 69, S 8, HVA 4251, I/A 45 (19.01.10).
18 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUPO DE NEGOCIOS DUERO SA;ENDESA GAS SA. Nombramientos. Consejero: ENDESAGAS SA. Datos registrales. T 995 , F 69, S 8, H VA 4251, I/A 44 ( 9.12.09).
24 de Agosto de 2009Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 995 , F 68, S 8, H VA 4251, I/A 42 (13.08.09).
Ceses/Dimisiones. Secretario: PACHECO PLAZA TERESA. Nombramientos. Secretario: FERNANDEZ DIAZ JIMENA. Datosregistrales. T 995 , F 69, S 8, H VA 4251, I/A 43 (13.08.09).