Actos BORME de Distritoledo Sl
20 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: JESUS LOPEZ DIAZ. Nombramientos. Apo.Manc.: ALFONSO RUIZ ESTEBAN. Datos registrales. T1757 , F 157, S 8, H TO 1826, I/A 40 (13.06.23).
18 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: JESUS LOPEZ DIAZ. Apo.Sol.: JESUS LOPEZ DIAZ. Apo.Manc.: MARTA BRAVO SILVA. Apo.Sol.:MARTA BRAVO SILVA. Apo.Manc.: ALBERTO PEREZ-FONTAN FERNANDEZ. Apo.Sol.: ALBERTO PEREZ-FONTAN FERNANDEZ.Datos registrales. T 1757 , F 157, S 8, H TO 1826, I/A 39 (11.04.23).
16 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: BELEN GARCIA VALENCIA. Apo.Manc.: JULIO VILLANUEVA RODRIGUEZ. Datos registrales. T 1706 , F225, S 8, H TO 1826, I/A 36 ( 9.03.23).
Nombramientos. Apo.Manc.: JESUS LOPEZ DIAZ;MARTA BRAVO SILVA;LIDIA PASAMAR LORENZO;LUIS ORTEGO MAGANO.Apo.Sol.: JESUS LOPEZ DIAZ;MARTA BRAVO SILVA;LUIS ORTEGO MAGANO;LIDIA PASAMAR LORENZO. Datos registrales. T
Nombramientos. Apoderado: ERNESTO SANTOS MARTIN. Datos registrales. T 1757 , F 156, S 8, H TO 1826, I/A 38 ( 9.03.23).
12 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA SL;BOYACA SERVICIOS CORPORATIVOS SL;IBAÑEZCAMPO MARIANO. Secretario: PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO. Presidente: DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACASL. Nombramientos. Adm. Unico: DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA SL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 1682 , F 220, S 8, H TO 1826, I/A 34(30.10.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: SERRANO BUSTAMANTE JORGE. Apo.Manc.: SERRANO BUSTAMANTE JORGE;CABALLERO JULIAFERNANDO. Apo.Sol.: CABALLERO JULIA FERNANDO. Apo.Manc.: QUINTANA ENRIQUE MIGUEL. Apo.Sol.: QUINTANAENRIQUE MIGUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: BRAVO SILVA MARTA;PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO. Apo.Sol.:BRAVO SILVA MARTA;PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 1682 , F 220, S 8, H TO 1826, I/A 35(30.10.20).
22 de Octubre de 2019Otros conceptos: Modificado el artículo 12 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 1682 , F 220, S 8, H TO 1826, I/A 33
01 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: GRUPO CRONOS DISTRIBUCION INTEGRAL SL. Presidente: GRUPO CRONOS DISTRIBUCIONINTEGRAL SL. Nombramientos. Consejero: BOYACA SERVICIOS CORPORATIVOS SL. Presidente: DISTRIBUCIONESGENERALES BOYACA SL. Datos registrales. T 1682 , F 219, S 8, H TO 1826, I/A 32 (25.07.19).
03 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO. Apo.Sol.: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;BERTOLO OTEROJOSE ROBERTO. Apo.Manc.: BERTOLO OTERO JOSE ROBERTO;SERRANO GONZALEZ CASTO MANUEL. Apo.Sol.: SERRANOGONZALEZ CASTO MANUEL. Apo.Manc.: QUINTANA ENRIQUE MIGUEL. Apo.Sol.: QUINTANA ENRIQUE MIGUEL. Apo.Manc.:LOPEZ DIAZ JESUS. Apo.Sol.: LOPEZ DIAZ JESUS. Nombramientos. Apo.Manc.: SERRANO BUSTAMANTEJORGE;CABALLERO JULIA FERNANDO;LOPEZ DIAZ JESUS;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL;VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO.Apo.Sol.: SERRANO BUSTAMANTE JORGE;CABALLERO JULIA FERNANDO;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL;LOPEZ DIAZJESUS;VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO. Datos registrales. T 1642 , F 211, S 8, H TO 1826, I/A 30 (27.03.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: OROVIOGOICOECHEA ORTEGA JORGE;MARTINEZ GUTIERREZ ESTHER;GARCIA VALENCIA BELEN.Nombramientos. Apo.Sol.: BRAVO SILVA MARTA;GARCIA VALENCIA BELEN;REINA VALENCIA ROBERTO. Datos registrales. T1682 , F 219, S 8, H TO 1826, I/A 31 (27.03.19).
20 de Marzo de 2018Otros conceptos: Designado don Julio-Alexander Villanueva Ruíz como persona física representante de la sociedad"DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA SL", consejero de la sociedad "DISTRITOLEDO SL". Datos registrales. T 1642 , F 211,S 8, H TO 1826, I/A 29 ( 8.03.18).
28 de Febrero de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: OROVIOGOICOECHEA ORTEGA JORGE. Apo.Manc.: OROVIOGOICOECHEA ORTEGAJORGE;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Apo.Sol.: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;ESLAVA REIG CARLOS. Apo.Manc.: ESLAVA REIGCARLOS;SERRANO GONZALEZ CASTO MANUEL. Apo.Sol.: SERRANO GONZALEZ CASTO MANUEL. Nombramientos.Apo.Manc.: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;BERTOLO OTERO JOSE ROBERTO;SERRANO GONZALEZ CASTOMANUEL;LOPEZ DIAZ JESUS. Apo.Sol.: VILLANUEVA RODRIGUEZ JULIO;BERTOLO OTERO JOSE ROBERTO;SERRANOGONZALEZ CASTO MANUEL;QUINTANA ENRIQUE MIGUEL;LOPEZ DIAZ JESUS. Apo.Manc.: QUINTANA ENRIQUE MIGUEL.Datos registrales. T 1642 , F 210, S 8, H TO 1826, I/A 28 (15.02.18).
01 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: CASTILLA PEINADO PEDRO. Apo.Sol.: CASTILLA PEINADO PEDRO. Apo.Manc.: IRIONDO ARRIOLAALBERTO. Apo.Sol.: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO. Apo.Manc.: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Apo.Sol.: ALCOBENDASMARTINEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;OROVIOGOICOECHEA ORTEGAJORGE;SERRANO GONZALEZ CASTO MANUEL;ESLAVA REIG CARLOS. Apo.Sol.: IRIONDO ARRIOLAALBERTO;OROVIOGOICOECHEA ORTEGA JORGE;SERRANO GONZALEZ CASTO MANUEL;ESLAVA REIG CARLOS. Datosregistrales. T 1597 , F 169, S 8, H TO 1826, I/A 26 (25.05.17).
Cambio de domicilio social. C/ RIO JARAMA 140B - POLIGONO INDUSTRIAL MARGARITA (TOLEDO). Datos registrales. T 1642, F 210, S 8, H TO 1826, I/A 27 (25.05.17).
27 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: OROVIOGOICOECHEA ORTEGA JORGE;GARCIA VALENCIA BELEN;MARTINEZ GUTIERREZESTHER. Datos registrales. T 1597 , F 168, S 8, H TO 1826, I/A 24 (20.06.16).
Revocaciones. Apoderado: GODOY MEDINA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 1597 , F 168, S 8, H TO 1826, I/A 25(20.06.16).
18 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ LIÑAN GERARDO;RUIZ ESTEBAN ALFONSO. Cons.Del.Sol: RUIZ ESTEBANALFONSO. Secretario: DIEZ PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero: DISTRIBUCIONES GENERALESBOYACA SL. Secretario: PEREZ-FONTAN FERNANDEZ ALBERTO. Datos registrales. T 1573 , F 36, S 8, H TO 1826, I/A 20(11.12.14).
Revocaciones. Apoderado: MORA ENCINAS JUAN MANUEL;MORA ENCINAS FRANCISCO JAVIER;MORA ENCINAS JOSELUIS;ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Apo.Sol.: ALCOBENDASMARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 1573 , F 36, S 8, H TO 1826, I/A 21 (11.12.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: CASTILLA PEINADO PEDRO;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS.Apo.Sol.: CASTILLA PEINADO PEDRO;IRIONDO ARRIOLA ALBERTO;ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T1573 , F 37, S 8, H TO 1826, I/A 22 (11.12.14).
Nombramientos. Apoderado: GODOY MEDINA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 1597 , F 168, S 8, H TO 1826, I/A 23(11.12.14).
18 de Junio de 2014Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENANTE PERSONA FISICA DEL CONSEJERO Y PRESIDENTE, GRUPO CRONOSDISTRIBUCION INTEGRAL SL, PASANDO A SER DON JULIO ALEXANDER VILLANUEVA RUIZ. Datos registrales. T 1573 , F 36,S 8, H TO 1826, I/A 19 (11.06.14).
29 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LOINAZ JAIME JOSE MARIA;ALONSO AGUADO PEDRO. Con.Delegado: LOINAZ JAIME JOSEMARIA. Secretario: ULECIA PALACIOS CARLOS. Nombramientos. Consejero: RUIZ ESTEBAN ALFONSO;DOMINGUEZ LIÑANGERARDO. Secretario: DIEZ PICAZO GIMENEZ MARIA TERESA. Cons.Del.Sol: RUIZ ESTEBAN ALFONSO. Datos registrales. T1429 , F 6, S 8, H TO 1826, I/A 17 (21.08.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: ALCOBENDAS MARTINEZ JOSE LUIS. Datosregistrales. T 1429 , F 6, S 8, H TO 1826, I/A 18 (21.08.13).
13 de Febrero de 2012Otros conceptos: Nombrado D. Juan Manuel Albelda Martín como representante persona física del consejero GRUPO CRONOSDISTRIBUCION INTEGRAL SL, en sustitución de D. Ovidio Ramón Cecos. Datos registrales. T 1429 , F 6, S 8, H TO 1826, I/A 16 (2.02.12).
04 de Octubre de 2010Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1429 , F 6, S 8, H TO 1826, I/A 15 (23.09.10).
19 de Enero de 2009Nombramientos. Con.Delegado: LOINAZ JAIME JOSE MARIA. Datos registrales. T 1429 , F 5, S 8, H TO 1826, I/A 14 ( 5.01.09).