Actos BORME de Disvace Sl
12 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 75, S 8, H V 25745, I/A 24 ( 5.09.23).
31 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ SANCHEZ ALBERTO FRANCISCO;SORIA BLASCO ANTONIO FELIX.Nombramientos. Consejero: MIRALLES SANCHEZ MARIA DEL CARMEN;VERASTEGUI SACRISTAN JORGE. Datos registrales.T 4488, L 1800, F 75, S 8, H V 25745, I/A 23 (24.05.23).
02 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: TORREGROSA MIRALLES ENRIQUE. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 75, S 8, H V 25745, I/A22 (26.07.22).
18 de Enero de 2021Reelecciones. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SL. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 75, S 8, H V 25745, I/A 21 ( 8.01.21).
11 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 75, S8, H V 25745, I/A 20 ( 4.07.17).
23 de Diciembre de 2014Fe de erratas: La fecha correcta del acuerdo es 14 de diciembre de 2010 y no la que por error aparece publicada en el Boletín 18 defecha 26/01/12 y referencia 00405942012. La fecha correcta del acuerdo es 14 de diciembre de 2010 y no la que por error aparecepublicada en el Boletín 18 de fecha 26/01/12 y referencia 00405942012. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 74, S 8, H V 25745, I/A16 (17.01.12).
Nombramientos. Auditor: EVIDENCE AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 4488, L 1800, F75, S 8, H V 25745, I/A 19 (16.12.14).
14 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ACITORES QUINTANA GERARDO. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZSANCHEZ ALBERTO FRANCISCO. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 74, S 8, H V 25745, I/A 18 ( 7.05.13).
19 de Julio de 2012Nombramientos. Auditor: EVIDENCE AUDITORES DE CUENTAS SLP. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 74, S 8, H V 25745, I/A17 (10.07.12).
26 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: SEVILLA CHANZA MARTA. Aud.Supl.: VALERO CANTERO ANGEL LUIS. Datos registrales. T 4488, L1800, F 74, S 8, H V 25745, I/A 16 (17.01.12).
26 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: CODOÑER GALLACH SANTIAGO. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 73, S 8, H V 25745, I/A 14(17.10.11).
Nombramientos. Apoderado: CODOÑER SOLA MARIO. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 73, S 8, H V 25745, I/A 15 (17.10.11).
22 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MIÑANA ARNAO RAMON GONZALO. Nombramientos. SecreNoConsj: FUERTES ALEGRECONCEPCION. Datos registrales. T 4488, L 1800, F 73, S 8, H V 25745, I/A 13 (11.02.11).
18 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: MIÑANA ARNAORAMON GONZALO. Consejero: TORREGROSA GOZALVEZ ENRIQUE;SORIA BLASCO ANTONIO FELIX;TORREGROSAMIRALLES ENRIQUE;DE JAUREGUIZAR SERRANO CARLOS;MARTINEZ ACITORES QUINTANA GERARDO. Presidente: