Buscador CIF Logo

Actos BORME Ditec Automoviles Barcelona Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ditec Automoviles Barcelona Sl

Actos BORME Ditec Automoviles Barcelona Sl - B66293135

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Ditec Automoviles Barcelona Sl con CIF B66293135

馃敊 Perfil de Ditec Automoviles Barcelona Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Ditec Automoviles Barcelona Sl

23 de Octubre de 2023
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: SEBASTIAN DE CARCER PRADO;TOMAS ETCHEVERRY SCHIRMER;JOSE LUIS ACU脩AVELASCO;JUAN CRISTOBAL LIRA IBA脩EZ;ALVARO PARDO GERARDO;MANUELA TERESA DE CARCERGOYCOOLEA;VELASCO MASO JOSE MANUEL;BAEZA CALVO JOSE;MARTINEZ RECH MARISOL. Datos registrales. T 45344 , F75, S 8, H B 453134, I/A 21 (13.10.23).

11 de Octubre de 2022
Nombramientos. APOD.SOL/MAN: SEBASTIAN DE CARCER PRADO;TOMAS ETCHEVERRY SCHIRMER;CRISTOBALLUTTECKE RECONDO;ALVARO PARDO GERARDO;FERRERAS GARCIA PEDRO;VELASCO MASO JOSE MANUEL;BAEZACALVO JOSE. Datos registrales. T 45344 , F 73, S 8, H B 453134, I/A 20 ( 4.10.22).

06 de Abril de 2022
Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO. NUEVO SOCIO UNICO: INVERSIONES DITES, SPA. Datos registrales. T 45344 ,F 73, S 8, H B 453134, I/A 19 (29.03.22).

17 de Noviembre de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CROWE AUDITORES ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 45344 , F 73, S 8, H B 453134, I/A 18 (9.11.21).

22 de Julio de 2020
Nombramientos. APODERAD.SOL: FERRERAS GARCIA PEDRO;PRADA GAUSI JORGE;VALENTIN SARALEGUI ALVARO.Datos registrales. T 45344 , F 72, S 8, H B 453134, I/A 17 (14.07.20).

11 de Junio de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: COSTABAL VALDES EDUARDO. Nombramientos. CONSEJERO: LIRA IBA脩EZ JUANCRISTOBAL. Datos registrales. T 45344 , F 72, S 8, H B 453134, I/A 16 ( 1.06.18).

01 de Febrero de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 45344 , F 72, S 8, H B 453134, I/A 15

05 de Enero de 2018
Revocaciones. APOD.MANCOMU: EDUARDO COSTABAL VALDES. Datos registrales. T 45344 , F 71, S 8, H B 453134, I/A 14(27.12.17).

29 de Noviembre de 2017
Nombramientos. APOD.MANCOMU: BAEZA CALVO JOSE. Datos registrales. T 45344 , F 71, S 8, H B 453134, I/A 13 (17.11.17).

25 de Julio de 2017
Revocaciones. V-SEC NO CON: VALLET VILA RAFAEL. Nombramientos. V-SEC NO CON: ALVARO PARDO GERARD. Datosregistrales. T 45344 , F 71, S 8, H B 453134, I/A 12 (17.07.17).

18 de Mayo de 2016
Revocaciones. APOD.MANCOMU: VELASCO MASO JOSE MANUEL;BAEZA CALVO JOSE. Nombramientos. APOD.SOL/MAN:VELASCO MASO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 44336 , F 48, S 8, H B 453134, I/A 11 ( 9.05.16).

27 de Enero de 2016
Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: SEBASTIAN DE CARCER PRADO;EDUARDO COSTABAL VALDES. Nombramientos.CONSEJERO: DE CARCER PRADO SEBASTIAN. PRESIDENTE: DE CARCER PRADO SEBASTIAN. CONSEJERO: TOMASETCHEVERRY SCHIRMER;COSTABAL VALDES EDUARDO. SECR.NO CONS: FERRERAS GARCIA PEDRO. V-SEC NO CON:VALLET VILA RAFAEL. Datos registrales. T 44336 , F 46, S 8, H B 453134, I/A 8 (19.01.16).

Revocaciones. APOD.MANCOMU: EDUARDO COSTABAL VALDES;FERRERAS DIEZ PEDRO;FERRERAS GARCIAPEDRO;VELASCO MASO JOSE MANUEL. Nombramientos. APOD.MANCOMU: EDUARDO COSTABAL VALDES;CRISTOBALLUTTECKE RECONDO;FERRERAS GARCIA PEDRO. Datos registrales. T 44336 , F 46, S 8, H B 453134, I/A 9 (19.01.16).

Nombramientos. APOD.MANCOMU: VELASCO MASO JOSE MANUEL;BAEZA CALVO JOSE. Datos registrales. T 44336 , F 47, S8, H B 453134, I/A 10 (19.01.16).

30 de Marzo de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.003.000,00 Euros. Datos registrales. T 44336 , F 45, S8, H B 453134, I/A 7 (20.03.15).

04 de Febrero de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: HORWATH PLM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 44336 , F 45, S 8, H B 453134, I/A 6(28.01.15).

22 de Octubre de 2014
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: SEBASTIAN DE CARCER PRADO;EDUARDO COSTABAL VALDES. Cambio de domiciliosocial. CL BOTANICA Num.89 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datos registrales. T 44336 , F 44, S 8, H B 453134, I/A 5(14.10.14).

15 de Octubre de 2014
Nombramientos. APOD.MANCOMU: VELASCO MASO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 44336 , F 43, S 8, H B 453134, I/A 4 (7.10.14).

25 de Julio de 2014
Nombramientos. APOD.MANCOMU: EDUARDO COSTABAL VALDES;FERRERAS DIEZ PEDRO;FERRERAS GARCIA PEDRO.Datos registrales. T 44336 , F 43, S 8, H B 453134, I/A 3 (16.07.14).

04 de Julio de 2014
Revocaciones. ADM.UNICO: FERRERAS GARCIA PEDRO. Nombramientos. ADM.UNICO: JUAN SEBASTIAN DE CARCERPRADO. Datos registrales. T 44336 , F 43, S 8, H B 453134, I/A 2 (26.06.14).

04 de Junio de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 12.05.14. Objeto social: COMERCIALIZACION MINORISTA DE CUALQUIER TIPO DEVEHICULOS DE MOTOR DE DOS O MAS RUEDAS,PIEZAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,ASI COMO ALQUILER DE DICHOSVEHICULOS,CON O SIN CONDUCTOR,ETC. Domicilio: CL TUSET 5-11 P.8 (BARCELONA). Capital: 3.000,00 Euros.Nombramientos. ADM.UNICO: FERRERAS GARCIA PEDRO. Otros conceptos: DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO SOCIO UNICO INMOBILIARIA DAYTONA SPA Datos registrales. T 44336 , F 41, S 8, H B 453134, I/A 1 (28.05.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n