Actos BORME de Ditecpol Sl
02 de Marzo de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 1650 , F 218, S 8, H TO 37227, I/A 12 (22.02.18).
22 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH;DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario:DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARK RANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Nombramientos.Adm. Solid.: DIAMOND ANDREW JOHN;HALE CLARK RANDOLPH. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1628 , F 220, S 8, H TO 37227, I/A 11 (15.01.18).
28 de Diciembre de 2017Otros conceptos: Modificaci贸n no esencial del proyecto de fusi贸n de fecha 23/06/2017, excluyendo a "KRIPSOL INTERMARKMALAGA, SL" del per铆metro de la fusi贸n y el traslado del domicilio social de "SUGAR VALLEY, SL", "FIBERPOOL INTERNACIONAL,SL" y "HAYWARD POOL ACQUISITION, SL", a Yuncos, Toledo, Calle Felipe II. Datos registrales. T 1628 , F 220, S 8, H TO 37227,I/A 10 m (14.12.17).
13 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZ MIGUEL. Apo.Manc.: RODRIGUEZGONZALEZ DE CANALES ALMUDENA. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: LOPEZ BLANCO ANGEL. Nombramientos. Apo.Sol.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Apo.Manc.: LACHANCE RICHARD;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALESALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 219, S 8, H TO 37227, I/A 10 ( 6.02.17).
19 de Enero de 2017Revocaciones. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1628 , F 219, S 8, H TO 37227, I/A 9(12.01.17).
21 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;DANA GESTION SL;REAL SIDI SL;CORPORACIONEMPRESARIAL UNEX SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: DAVIS ROBERTMICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Apo.Sol.: DAVIS ROBERT MICHAEL;DIAMOND ANDREW JOHN. Consejero: HALE CLARKRANDOLPH. Presidente: DAVIS ROBERT MICHAEL. Secretario: DIAMOND ANDREW JOHN. Con.Delegado: HALE CLARKRANDOLPH. Datos registrales. T 1604 , F 120, S 8, H TO 37227, I/A 6 (15.09.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARROFE PUJOL ALBERT;FABREGA RODRIGUEZ-RODA ANNA;SALA CLIMENT MARIATERESA;BIDAGUREN URBIETA MIREN;RIVERA GARCIA DIANA. Datos registrales. T 1628 , F 217, S 8, H TO 37227, I/A 7(15.09.16).
Revocaciones. Apoderado: ALCAINE GIL JESUS-MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZMIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA SANCHEZMIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL.Apo.Manc.: GARCIA SANCHEZMIGUEL;RODRIGUEZ GONZALEZ DE CANALES ALMUDENA;LOPEZ BLANCO ANGEL. Datos registrales. T 1628 , F 217, S 8, HTO 37227, I/A 8 (15.09.16).
11 de Julio de 2016Otros conceptos: CAMBIADO EL REPRESENTANTE PERSONA FISICA DE LA SOCIEDAD "DANA GESTION" PASANDO A SERDON ELIO LEVI, CON N.I.E. X0708018D. Datos registrales. T 1604 , F 120, S 8, H TO 37227, I/A 5 ( 4.07.16).
13 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAISSL;DANA GESTION SL;REAL SIDI SL;CORPORACION EMPRESARIAL UNEX SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario:PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo deadministraci贸n. Datos registrales. T 1604 , F 119, S 8, H TO 37227, I/A 4 ( 5.10.15).
04 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: REAL SIDI SL;JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario:PRIMBRAIS SL. Nombramientos. Adm. Solid.: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 1604 , F 118, S 8, H TO 37227, I/A 3(23.04.15).
21 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. C/ FELIPE II 59-65 - POLIGONO INDUSTRIAL LA VILLA (YUNCOS). Datos registrales. T 1604 , F
31 de Diciembre de 2014Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2009 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2010 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del RegistroMercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediante certificacion delorgano de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas delejercicio 2011 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1353 , F 162, S 8, H SS 6976, I/A 26(15.12.14).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORO GARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1353 , F 162, S 8, H SS 6976, I/A 27(15.12.14).
Nombramientos. Auditor: GAFISA BARCELONA AUDITORS SLP. Datos registrales. T 1353 , F 163, S 8, H SS 6976, I/A 28(15.12.14).
29 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: DANA GESTION SL;ALCAINE GIL JESUS-MARIA;BITU MARIA OCTAVIANA. Secretario: DANAGESTION SL. Presidente: ALCAINE GIL JESUS-MARIA. Nombramientos. Consejero: JOIMA ALBA SL;PRIMBRAIS SL;REAL SIDISL. Presidente: JOIMA ALBA SL. Secretario: PRIMBRAIS SL. Datos registrales. T 1351 , F 208, S 8, H SS 6976, I/A 24 (21.08.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA SANCHEZ MIGUEL;ALMAGRO RECIO ANA MARIA;ALCAINE ZAPATA ISRAEL;MOROGARRUDO FERNANDO. Datos registrales. T 1351 , F 208, S 8, H SS 6976, I/A 25 (21.08.13).
25 de Julio de 2013Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2008 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2009 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del RegistroMercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2010 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2011 mediante certificacion delorgano de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas delejercicio 2012 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 1351 , F 208, S 8, H SS 6976, I/A 22(17.07.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LEVI ELIO. Secretario: LEVI ELIO. Nombramientos. Secretario: DANA GESTION SL. Consejero:DANA GESTION SL. Datos registrales. T 1351 , F 208, S 8, H SS 6976, I/A 23 (17.07.13).
05 de Enero de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: KRIPSOL GESTION SL. Nombramientos. Consejero: ALCAINE GIL JESUS-MARIA;LEVIELIO;BITU MARIA OCTAVIANA. Presidente: ALCAINE GIL JESUS-MARIA. Secretario: LEVI ELIO. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Otros conceptos: MODIFICAC. DE LOSARTICULOS 16潞 Y 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, RELATIVOS AL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T1351 , F 207, S 8, H SS 6976, I/A 20 (27.12.10).
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2005 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2006 mediante certificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro