Buscador CIF Logo

Actos BORME Ditransco Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ditransco Sl

Actos BORME Ditransco Sl - B25338450

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Lleida para Ditransco Sl con CIF B25338450

馃敊 Perfil de Ditransco Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Lleida

Actos BORME de Ditransco Sl

30 de Junio de 2022
Reelecciones. Adm. Mancom.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 489 , F 40, S8, H L 6483, I/A 46 (22.06.22).

24 de Febrero de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 489 , F 39, S 8, H L 6483, I/A 45(12.02.21).

22 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: AZLOR MARSI脩ACH JORDI. Datos registrales. T 489 , F 39, S 8, H L 6483, I/A 44 ( 3.12.20).

24 de Febrero de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 489 , F 39, S 8, H L 6483, I/A 43(17.02.20).

14 de Marzo de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 489 , F 39, S 8, H L 6483, I/A 42 (7.03.19).

07 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: PERALTA CAMPO FERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: PAJUELO PAJUELO JUAN. Apo.Manc.:PAJUELO PAJUELO JUAN;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 487 , F 114, S 8, H L 6483, I/A 41 ( 1.02.19).

28 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 487 , F 113, S 8, H L 6483, I/A 40(21.02.18).

17 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Manc.: MONTULL BURILLOALEJANDRO. Apo.Sol.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 487 , F 113, S 8, H L 6483, I/A 39 ( 9.10.17).

28 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: CEREZO MURILLO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 487 , F 110, S 8, H L 6483, I/A 38(20.07.17).

06 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS. Nombramientos. Adm.Mancom.: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 487 , F 100, S 8, H L 6483, I/A 36(26.06.17).

Revocaciones. Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;URBIOLA CORTASA OSCAR;ESPINET FERNANDEZSEBASTIA;URBIOLA CORTASA OSCAR;GARCIA GARCIA JOSE;GIL BALAGUERO JORDI. Apo.Sol.: GIL BALAGUEROJORDI;URBIOLA CORTASA OSCAR. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCO ANA MARIA;GARCIA GARCIAJOSE;GIL BALAGUERO JORDI. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA JOSE;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Manc.: VILLENACONTRERAS LUIS. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS. Nombramientos. Apoderado: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULLBURILLO ALEJANDRO;GIL BALAGUERO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR. Datos registrales. T 487 ,F 101, S 8, H L 6483, I/A 37 (26.06.17).

30 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERASLUIS;MONTULL BURILLO ALEJANDRO. Datos registrales. T 487 , F 57, S 8, H L 6483, I/A 35 ( 8.05.17).

10 de Febrero de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 487 , F 57, S 8, H L 6483, I/A 34 (3.02.17).

05 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO;SORIANO SANCHEZ ENRIQUE;BARO DURICH ELOI;MONTULLBURILLO ALEJANDRO;BARO DURICH ELOI;MARTIN GONZALEZ ANGELES;GARCIA CRUCES MARIA PILAR.Apoderado: LOPEZVILLAR MANUEL. Datos registrales. T 485 , F 78, S 8, H L 6483, I/A 33 (27.04.16).

08 de Marzo de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 485 , F 77, S 8, H L 6483, I/A 32(26.02.16).

10 de Junio de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIAGARCIA JOSE;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;URBIOLA CORTASA OSCAR;VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCOANA MARIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERASLUIS;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE. Nombramientos. Apo.Sol.: ESPINETFERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCO ANA MARIA;GIL BALAGUEROJORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR;GARCIA GARCIA JOSE;GIL BALAGUERO JORDI;VILLENACONTRERAS LUIS;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA. Apo.Sol.: URBIOLA CORTASA OSCAR;GARCIA GARCIA JOSE;GILBALAGUERO JORDI;VILLENA CONTRERAS LUIS. Apo.Manc.: URBIOLA CORTASA OSCAR;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA.Datos registrales. T 485 , F 56, S 8, H L 6483, I/A 31 ( 1.06.15).

09 de Marzo de 2015
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 485 , F 56, S 8, H L 6483, I/A 30( 2.03.15).

29 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: AZLOR MARSI脩ACH JORDI. Datos registrales. T 483 , F 192, S 8, H L 6483, I/A 29 (22.04.14).

18 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apoderado: PERALTA CAMPO FERNANDO. Datos registrales. T 483 , F 94, S 8, H L 6483, I/A 28 (10.03.14).

06 de Marzo de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 483 , F 94, S 8, H L 6483, I/A 27(21.02.14).

16 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: HEREU CLAVEL JOSE MARIA. Apo.Manc.: HEREU CLAVEL JOSE MARIA;HEREU CLAVEL JOSE MARIA.Datos registrales. T 479 , F 194, S 8, H L 6483, I/A 25 (10.12.13).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SORIGUE SA. Datos registrales. T 483 , F 94, S 8, H L 6483, I/A 26 (10.12.13).

14 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: MONTULL BURILLO ALEJANDRO;BARO DURICH ELOI. Datos registrales. T 479 , F 193, S 8, H L6483, I/A 24 ( 7.05.13).

06 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 479 , F 193, S 8, H L 6483, I/A 23(29.01.13).

31 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CASTELLS FARRAS JOAN;NADAL CLARET EDUARDO. Nombramientos. Adm. Mancom.:ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS. Datos registrales. T 479 , F 169, S 8, H L 6483, I/A 21 (22.01.13).

Revocaciones. Apoderado: HEREU CLAVEL JOSE MARIA. Apo.Manc.: HEREU CLAVEL JOSE MARIA;CASTELLS FARRASJOAN;NADAL CLARET EDUARDO;HEREU CLAVEL JOSE MARIA;CASTELLS FARRAS JOAN;NADAL CLARET EDUARDO;GARCIAGARCIA JOSE;VILLENA CONTRERAS LUIS;BERNAT NIUBO JORDI;HEREU CLAVEL JOSE MARIA. Apo.Sol.: BERNAT NIUBOJORDI;NADAL CLARET EDUARDO;CASTELLS FARRAS JOAN. Apo.Manc.: CASTELLS FARRAS JOAN;BERNAT NIUBO JORDI.Apo.Sol.: NADAL CLARET EDUARDO. Apo.Manc.: NADAL CLARET EDUARDO. Apo.Sol.: GARCIA GARCIA JOSE;CASTELLSFARRAS JOAN. Apo.Manc.: VILLENA CONTRERAS LUIS;GARCIA GARCIA JOSE. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS;HEREUCLAVEL JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Sol.: VILLENA CONTRERAS LUIS;HEREU CLAVEL JOSE MARIA;ESPINETFERNANDEZ SEBASTIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE. Apo.Manc.: ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENACONTRERAS LUIS;HEREU CLAVEL JOSE MARIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASAOSCAR;ESPINET FERNANDEZ SEBASTIA;VILLENA CONTRERAS LUIS;VALLES BLASCO ANA MARIA;HEREU CLAVEL JOSEMARIA;BERNAT NIUBO JORDI;GARCIA GARCIA JOSE;URBIOLA CORTASA OSCAR. Datos registrales. T 479 , F 170, S 8, H L6483, I/A 22 (22.01.13).

01 de Febrero de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 479 , F 169, S 8, H L 6483, I/A 20(23.01.12).

15 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 479 , F 169, S 8, H L 6483, I/A 19 (4.02.11).

15 de Abril de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 479 , F 169, S 8, H L 6483, I/A 18 (1.04.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n